SIR ROBERT MCALPINE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SIR ROBERT MCALPINE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00566823 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
- Construcción de carreteras y autopistas (42110) / Construcción
- Construcción de ferrocarriles y metros (42120) / Construcción
- Construcción de puentes y túneles (42130) / Construcción
¿Dónde se encuentra SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Concept House Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Hertfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SIR ROBERT MCALPINE & SONS,LIMITED | 31 may 1956 | 31 may 1956 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 oct 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 jul 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr James Leighton More el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen William Hudson como director el 01 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Grant Robert Findlay como director el 01 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Hunter como director el 01 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Lorna Jean Emmett como secretario el 08 ago 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Miss Karen Joy Brookes el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Christopher Martin el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter Dominic Leonard el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Hunter el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stephen William Hudson el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Grant Robert Findlay el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Edward Thomas William Mcalpine el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Hector George Mcalpine el 18 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr John Alistair Dempsey el 17 jul 2025 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Modification des détails de Sir Robert Mcalpine (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jun 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Eaton Court Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 7TR a Concept House Home Park Mill Link Kings Langley Hertfordshire WD4 8UD el 23 jun 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin John Pearson como secretario el 28 abr 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2024 | 88 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 mar 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 31 oct 2024
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stephen William Hudson el 01 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Dominic Leonard como director el 01 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Antony Richard Gates como director el 31 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2023 | 93 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMPSEY, John Alistair | Secretario | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | 179472470001 | |||||||
| EMMETT, Lorna Jean | Secretario | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | 338948520001 | |||||||
| BROOKES, Karen Joy | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 161172220001 | |||||
| LEONARD, Peter Dominic | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 280048870001 | |||||
| MARTIN, Neil Christopher | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 317424620001 | |||||
| MCALPINE, Hector George | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 137097930003 | |||||
| MCALPINE, Robert Edward Thomas William | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 137097830002 | |||||
| MORE, James Leighton | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 96473500003 | |||||
| COWEN, Brendon Raymond | Secretario | 92 Eastmoor Park AL5 1BP Harpenden Hertfordshire | British | 1234020001 | ||||||
| PEARSON, Kevin John | Secretario | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | British | 106469170001 | ||||||
| WALKER, Robert Peter | Secretario | 30 The Copse Fields End HP1 2TA Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 11492400001 | ||||||
| WALKER, Robert Peter | Secretario | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | British | 11492400001 | ||||||
| WALKER, Robert Peter | Secretario | 30 The Copse Fields End HP1 2TA Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 11492400001 | ||||||
| AIKENHEAD, Anthony | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | United Kingdom | British | 34755450002 | |||||
| BARRATT, Anthony William | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | United Kingdom | British | 67877120001 | |||||
| BOYLE, David Millar | Director | 14 Pencil View KA30 8JZ Largs Ayrshire | Scotland | British | 19302510002 | |||||
| CHRISTIE, Vincent William | Director | Penbury Burtons Lane HP8 4BB Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 10883860001 | ||||||
| COLLARD, Michael John | Director | Birds Oak Leatherhead Road KT22 0JJ Oxshott Surrey | British | 49634040001 | ||||||
| CORRIGAN, Vincent | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | United Kingdom | British | 103205770001 | |||||
| COX, Alison Lucia | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | England | British | 77182440005 | |||||
| FINDLAY, Grant Robert | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | England | British | 270482290001 | |||||
| GATES, Antony Richard | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 165339210001 | |||||
| HAMER, Paul Christopher | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 104678020002 | |||||
| HUDSON, Stephen William | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 308815430001 | |||||
| HUNTER, Andrew | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 308842590001 | |||||
| KELLY, Patrick Benedict | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | British | 35359500002 | ||||||
| LEGGOTT, Paul Edward | Director | Oak House Grosvenor Close SK9 1QY Wilmslow Cheshire | British | 44269440001 | ||||||
| MCALPINE, Andrew William, Sir | Director | Tyne House 23 Side NE1 3JL Newcastle Upon Tyne | British | 92904640002 | ||||||
| MCALPINE, Cullum | Director | 40 Bernard Street WC1N 1LG London | British | 10866460001 | ||||||
| MCALPINE, David Malcolm, The Hon | Director | 40 Bernard Street WC1N 1LG London | United Kingdom | British | 9834560002 | |||||
| MCALPINE, Gavin Malcolm | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire England | England | British | 197536940001 | |||||
| MCALPINE, Ian Malcolm | Director | 40 Bernard Street WC1N 1LG London | England | British | 10866480001 | |||||
| MCALPINE, Malcolm Hugh Dees | Director | 40 Bernard Street WC1N 1LG London | United Kingdom | British | 17907340002 | |||||
| MCALPINE, Richard Hugh | Director | 40 Bernard Street WC1N 1LG London | British | 9335550001 | ||||||
| MCALPINE, William Hepburn, Sir | Director | 40 Bernard Street WC1N 1LG London | United Kingdom | British | 267620004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SIR ROBERT MCALPINE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir Robert Mcalpine (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0