RUBIX U.K. LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RUBIX U.K. LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00569290 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RUBIX U.K. LIMITED?
- Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos (46690) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra RUBIX U.K. LIMITED?
| Dirección de la sede social | Dakota House Concord Business Park M22 0RR Manchester England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUBIX U.K. LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRAMMER UK LIMITED | 03 ene 2007 | 03 ene 2007 |
| BSL BRAMMER LIMITED | 31 ene 2005 | 31 ene 2005 |
| BSL LIMITED | 25 ene 1990 | 25 ene 1990 |
| BEARING SERVICE LIMITED | 23 jul 1956 | 23 jul 1956 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RUBIX U.K. LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RUBIX U.K. LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUBIX U.K. LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 53 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 52 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Sarah Shaw como director el 31 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 52 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Rubix International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 dic 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Bowring como director el 20 feb 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 52 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed brammer uk LIMITED\certificate issued on 01/09/22 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Segunda presentación para la terminación de Cecile Parker como director | 5 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Cécile Parker como director el 02 feb 2022 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Robert Graham Dixon como director el 21 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Vincent Michael Benedict Mcgurk como director el 18 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Registro de la carga 005692900007, creada el 14 ene 2022 | 21 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Helen Sarah Shaw como director el 17 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 48 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Rubix International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 dic 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Claverton Court Claverton Road Wythenshawe Manchester M23 9NE a Dakota House Concord Business Park Manchester M22 0RR el 16 dic 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RUBIX U.K. LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWRING, Richard | Director | Concord Business Park M22 0RR Manchester Dakota House England | United Kingdom | British | 265039130001 | |||||
| MCGURK, Vincent Michael Benedict | Director | Concord Business Park M22 0RR Manchester Dakota House England | England | British | 197598780001 | |||||
| BUTLER, John William | Secretario | Little Garth Tirley Lane CW6 0JZ Utkinton Cheshire | British | 89090380002 | ||||||
| KAVANAGH, Michael John | Secretario | 28 Pasture Field Road Peel Hall M22 5JU Manchester Lancashire | British | 7442440001 | ||||||
| SCARRATT, Andrew Nigel | Secretario | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | British | 11376090002 | ||||||
| SHELTON, David | Secretario | 63 Higher Lane WA13 0BZ Lymm Cheshire | British | 69563120005 | ||||||
| SOUTHERN, David | Secretario | Holly Trees Church Farm Podington NN29 THS Wellingborough Northamptonshire | British | 162259710001 | ||||||
| ASHMORE, Stephen, Mr. | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | England | British | 232880380001 | |||||
| BUTLER, John William | Director | Little Garth Tirley Lane CW6 0JZ Utkinton Cheshire | England | British | 89090380002 | |||||
| COOPER, Anthony Bernard | Director | 9 Packsaddle Park Prestbury SK10 4PU Macclesfield Cheshire | British | 7442490003 | ||||||
| DAVIS, Robert William | Director | 6 Bankfield Drive Holmbridge HD9 2PH Huddersfield West Yorkshire | England | British | 87301370001 | |||||
| DIXON, Mark Robert Graham | Director | Concord Business Park M22 0RR Manchester Dakota House England | England | British | 51467220005 | |||||
| FFOULKES-JONES, Robert Garson | Director | The Cliff Cliff Road Acton Bridge CW8 3QP Northwich Cheshire | British | 12535400001 | ||||||
| FRASER, Ian Robert | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | England | British | 28474370002 | |||||
| GRENNAN, Michael Anthony | Director | 61 Ganton Road WS3 3XQ Walsall West Midlands | British | 26531410001 | ||||||
| HODKINSON, Steven Paul | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | England | British | 207071940001 | |||||
| HOLLYWOOD, David John | Director | Stoney Way Bovingdon Green SL7 2JH Marlow Buckinghamshire | England | British | 114080730001 | |||||
| HOLMES, Barrington Peter | Director | 48 Meadow Drive Prestbury SK10 4EZ Macclesfield Cheshire | British | 11376100001 | ||||||
| HOLROYD, Gary | Director | Woodside 9 The Barkery Newby TS8 0AW Middlesbrough | British | 93490550001 | ||||||
| JACKSON, Lawrence | Director | 3 Turnberry Court NG12 4DL Edwalton | British | 93072990001 | ||||||
| JENNINGS, Paul | Director | Miskin House Grange Close LN1 2UY Ingham Lincolnshire | England | British | 75844470001 | |||||
| JONES, Graham Rhys | Director | 3 Greystokes Aughton L39 5HE Ormskirk Lancashire | England | British | 11743340002 | |||||
| MAGRATH, Duncan Jonathan | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | United Kingdom | British | 167161300001 | |||||
| MANNERING, Jeffrey | Director | 6 The Beeches WA6 0QL Helsby Cheshire | England | British | 127528160001 | |||||
| MILLER, John Charles | Director | 18 Keepier Wharf 12 Narrow Street E14 8DH London | United Kingdom | British | 81543110001 | |||||
| MILLS, Roger Harold Simpson | Director | 7 Madeley Close Hale WA14 3NJ Altrincham Cheshire | British | 2084770001 | ||||||
| PARK, Charlotte Katherine | Director | 6 Hill Carr Saint Margarets Road WA14 2BE Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 71869510001 | |||||
| PARKER, Cécile | Director | Concord Business Park M22 0RR Manchester Dakota House England | England | French | 255607530001 | |||||
| RITCHIE, Ian Alexander | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | United Kingdom | British | 94851550006 | |||||
| ROGERS, Neil John Heber | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | England | British | 217559740001 | |||||
| SCARRATT, Andrew Nigel | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | United Kingdom | British | 11376090002 | |||||
| SHAW, Helen Sarah | Director | Concord Business Park M22 0RR Manchester Dakota House England | England | British | 189453380001 | |||||
| SHELTON, David | Director | 63 Higher Lane WA13 0BZ Lymm Cheshire | British | 69563120005 | ||||||
| SHENTON, Garth | Director | 110 Broomhill Road BS4 4SA Bristol Avon | British | 30095770001 | ||||||
| SHORT, Christopher David | Director | Claverton Court Claverton Road M23 9NE Wythenshawe Manchester | United Kingdom | British | 102462770003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RUBIX U.K. LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubix International Limited | 06 abr 2016 | 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0