OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED

OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00574598
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OYEZSTRAKER LOGISTICS LIMITED22 oct 199822 oct 1998
    OYEZ STRAKER LOGISTICS LIMITED04 dic 199704 dic 1997
    STRAKER (GROUP) LIMITED29 sept 199329 sept 1993
    STRAKER (HOLDINGS) LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    STRAKER OFFICE SUPPLIES LIMITED 31 dic 198031 dic 1980
    STRAKER OFFICE SUPPLIES LIMITED 31 dic 197931 dic 1979
    L.B.JONES & COMPANY LIMITED22 nov 195622 nov 1956

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    12 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 jul 2022

    10 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    13 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 jul 2021

    10 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 08 jul 2020

    LRESEX

    Declaración de asuntos

    8 páginasLIQ02

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 4 500 Purley Way Croydon Surrey CR0 4NZ a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR el 27 jul 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Richard John Oates como director el 17 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Graham Mobbs como director el 17 ene 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cessation de Jonathan Paul Moulton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC07

    Notification de Officezone Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Michael Jones como director el 19 jun 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen James Horne como director el 04 mar 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jeffrey Michael Whiteway como director el 18 ene 2019

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 005745980016, creada el 23 nov 2018

    60 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    5 páginasAA

    Cancelación total de la carga 005745980011

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MAYNARD, Philippa Anne
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Secretario
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary44140850002
    HARVELL, David John
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Director
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector116748920001
    HINDMARCH, Nigel
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Director
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector90859340002
    HORNE, Stephen James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Director
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive256352360001
    OATES, Richard John
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    Director
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4 C/O Officeteam
    England
    United KingdomBritishCommercial Director198603960001
    ROBBINS, Ian Keith
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Director
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector79770200002
    RUSSELL, Sally Anne
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Director
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector147596000001
    BLANCHARD, Lisa Anne
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    Secretario
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    British40576530001
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Secretario
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    British67707480001
    PARNELL, Julie Caroline
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    Secretario
    45 Hilldale Road
    SM1 2JA Cheam
    Surrey
    BritishSecretary25488170003
    ALUN-JONES, Derek (John Derek), Sir
    The Willows
    KT24 5JE Effingham Common
    Surrey
    Director
    The Willows
    KT24 5JE Effingham Common
    Surrey
    BritishCompany Director28440590001
    APPLETON, William John
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Director
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director55953830001
    COSSEY, Paul
    35 Somerville Road
    SE20 7NA London
    Director
    35 Somerville Road
    SE20 7NA London
    BritishCompany Director68690040001
    COX, David
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    Director
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director70818680001
    DALE, Nicholas Robin
    19 Roseacre Lane
    Bearsted
    ME14 4HZ Maidstone
    Kent
    Director
    19 Roseacre Lane
    Bearsted
    ME14 4HZ Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishAccountant65374210001
    EADES, Lisa Anne
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    Director
    156 Casewick Road
    West Norwood
    SE27 0SZ London
    BritishAccountant40576530002
    GRAINGER, Terence Arthur
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Director
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director55826910002
    GRAY, David Peter
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    Director
    28a Chaldon Common Road
    CR3 5DA Caterham
    Surrey
    BritishCompany Director67707480001
    HEYS, David Michael
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Director
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishI T Director71032080003
    JONES, Christopher Michael
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Director
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishManager90859250001
    LANDSBERG, Kenneth William
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    Director
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    BritishChartered Accountant67271850002
    LEENDERS, Ilse
    30 Baccara Grove
    Bletchley
    MK2 3AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    30 Baccara Grove
    Bletchley
    MK2 3AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishI T Director71032040001
    LITTLEWOOD, John Nigel
    Mavins Court Greenhill Road
    GU9 8JN Farnham
    Surrey
    Director
    Mavins Court Greenhill Road
    GU9 8JN Farnham
    Surrey
    BritishCompany Director13384060001
    MCCALLUM, Alexander James
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    Director
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    United KingdomBritishAccountant93679470001
    MOBBS, Andrew Graham
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Director
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant100613070001
    MUSGRAVE HILL, Karen
    Abbey Farm
    Mitford
    NE61 2YN Morpeth
    Northumberland
    Director
    Abbey Farm
    Mitford
    NE61 2YN Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector48779830001
    PARBURY, Susanna Patricia
    5 Earlsdon Avenue South
    Earlsdon
    CV5 6DU Coventry
    West Midlands
    Director
    5 Earlsdon Avenue South
    Earlsdon
    CV5 6DU Coventry
    West Midlands
    BritishManaging Director33670410001
    PITT, Derek Neil
    160 Shirehall Road
    DA2 7SN Hawley
    Kent
    Director
    160 Shirehall Road
    DA2 7SN Hawley
    Kent
    BritishSales Director14385530003
    RITCHIE, Garry
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Director
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishDirector147482400001
    SEAR, Hugh Edward
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    Director
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    EnglandEnglishAccountant47246600001
    SEWARD, Timothy Clifton
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    Director
    Whiteposts 2 The Netherlands
    CR5 1ND Coulsdon
    Surrey
    BritishDirector51783710001
    SPEAR, David John
    12 Chatfield Road
    Cuckfield
    RH17 5BB Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    12 Chatfield Road
    Cuckfield
    RH17 5BB Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector16030100001
    STRAKER, Jonathan
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    Director
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    BritishCompany Director10770260001
    WHITEWAY, Jeffrey Michael
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    Director
    Unit 4
    500 Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Surrey
    EnglandBritishDirector14385570002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Jonathan Paul Moulton
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    06 abr 2016
    Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    10
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Guernsey
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4
    England
    06 abr 2016
    Purley Way
    CR0 4NZ Croydon
    Unit 4
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02848787
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 nov 2018
    Entregado el 29 nov 2018
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • BECAP12 Gp Limited as General Partner of BECAP12 Gp LP as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transacciones
    • 29 nov 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 17 jul 2015
    Entregado el 20 jul 2015
    Pendiente
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC as Receivables Purchaser, Inventory Lender and Property Lender and Lloyds Bank Commercial Finance Limited as Agent (Together "Lloyds")
    Transacciones
    • 20 jul 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 14 ago 2014
    Entregado el 18 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Becap 12 Gp Limited Acting in Its Capaciy as General Partner of BECAP12 Gp LP, Acting in Its Capacity as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transacciones
    • 18 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 24 jul 2014
    Entregado el 08 ago 2014
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • BECAP12 Gp Limited
    Transacciones
    • 08 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 24 jul 2014
    Entregado el 08 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • BECAP12 Gp Limited
    Transacciones
    • 08 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 12 jun 2013
    Entregado el 22 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 22 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 24 ene 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 12 jun 2013
    Entregado el 20 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 20 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 05 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Accession deed
    Creado el 17 dic 2008
    Entregado el 19 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 dic 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 abr 2003
    Entregado el 10 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 10 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 31 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 abr 2003
    Entregado el 10 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 10 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined)
    Creado el 30 abr 2001
    Entregado el 15 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 01 sept 1997
    Entregado el 11 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Bank of Scotland Treasury Services PLC
    Transacciones
    • 11 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage deed
    Creado el 26 nov 1988
    Entregado el 14 dic 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £29,600 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H 3 the boulevard balham high road london title nos sgl 24069 sgl 304952.
    Personas con derecho
    • Halifax Building Society
    Transacciones
    • 14 dic 1984Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 05 ene 1988
    Entregado el 12 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ene 1988Registro de una carga
    • 27 ene 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 4/10/85
    Creado el 13 sept 1985
    Entregado el 15 oct 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £18,750 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    Breve descripción
    All & whole that dwellinghouse known as no 3 with courtyard attached in the development by holm farm homes limited being the southwestmost of 3 dwelling houses, formed or to be formed from part of northmost part of the range of buildings k/a mount melville steading mount melville, holmsfarm saint andrews, fife.
    Personas con derecho
    • Standard Property Investment P.L.C.
    Transacciones
    • 15 oct 1985Registro de una carga
    • 09 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security registered at sasines on 16/7/85
    Creado el 10 jul 1985
    Entregado el 18 jul 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Dwelling house k/a number three with courtyard attached in the development by holm farm homes limited at mount melville, st. Andrews, fife being the southwestmost of 3 dwelling houses formed or to be formed from part of the northmostpart of a range of buildings k/a mount melville steading mount melville holm farm, st. Andrews for details see doc M82.
    Personas con derecho
    • Abbey National Building Society.
    Transacciones
    • 18 jul 1985Registro de una carga
    • 09 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 jul 2020Inicio de la liquidación
    12 dic 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Profesional
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Profesional
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0