OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00574598 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds West Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
OYEZSTRAKER LOGISTICS LIMITED | 22 oct 1998 | 22 oct 1998 |
OYEZ STRAKER LOGISTICS LIMITED | 04 dic 1997 | 04 dic 1997 |
STRAKER (GROUP) LIMITED | 29 sept 1993 | 29 sept 1993 |
STRAKER (HOLDINGS) LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
STRAKER OFFICE SUPPLIES LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
STRAKER OFFICE SUPPLIES LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
L.B.JONES & COMPANY LIMITED | 22 nov 1956 | 22 nov 1956 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 12 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 jul 2022 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 13 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 07 jul 2021 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de asuntos | 8 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 4 500 Purley Way Croydon Surrey CR0 4NZ a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR el 27 jul 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard John Oates como director el 17 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Graham Mobbs como director el 17 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cessation de Jonathan Paul Moulton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Officezone Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Michael Jones como director el 19 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen James Horne como director el 04 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeffrey Michael Whiteway como director el 18 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Registro de la carga 005745980016, creada el 23 nov 2018 | 60 páginas | MR01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 005745980011 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYNARD, Philippa Anne | Secretario | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | British | Company Secretary | 44140850002 | |||||
HARVELL, David John | Director | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 116748920001 | ||||
HINDMARCH, Nigel | Director | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 90859340002 | ||||
HORNE, Stephen James | Director | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 256352360001 | ||||
OATES, Richard John | Director | Purley Way CR0 4NZ Croydon Unit 4 C/O Officeteam England | United Kingdom | British | Commercial Director | 198603960001 | ||||
ROBBINS, Ian Keith | Director | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 79770200002 | ||||
RUSSELL, Sally Anne | Director | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 147596000001 | ||||
BLANCHARD, Lisa Anne | Secretario | 156 Casewick Road West Norwood SE27 0SZ London | British | 40576530001 | ||||||
GRAY, David Peter | Secretario | 28a Chaldon Common Road CR3 5DA Caterham Surrey | British | 67707480001 | ||||||
PARNELL, Julie Caroline | Secretario | 45 Hilldale Road SM1 2JA Cheam Surrey | British | Secretary | 25488170003 | |||||
ALUN-JONES, Derek (John Derek), Sir | Director | The Willows KT24 5JE Effingham Common Surrey | British | Company Director | 28440590001 | |||||
APPLETON, William John | Director | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 55953830001 | ||||
COSSEY, Paul | Director | 35 Somerville Road SE20 7NA London | British | Company Director | 68690040001 | |||||
COX, David | Director | Marloes Comp Lane St Marys Platt TN15 8NR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Company Director | 70818680001 | ||||
DALE, Nicholas Robin | Director | 19 Roseacre Lane Bearsted ME14 4HZ Maidstone Kent | United Kingdom | British | Accountant | 65374210001 | ||||
EADES, Lisa Anne | Director | 156 Casewick Road West Norwood SE27 0SZ London | British | Accountant | 40576530002 | |||||
GRAINGER, Terence Arthur | Director | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 55826910002 | ||||
GRAY, David Peter | Director | 28a Chaldon Common Road CR3 5DA Caterham Surrey | British | Company Director | 67707480001 | |||||
HEYS, David Michael | Director | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | United Kingdom | British | I T Director | 71032080003 | ||||
JONES, Christopher Michael | Director | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | United Kingdom | British | Manager | 90859250001 | ||||
LANDSBERG, Kenneth William | Director | 1 Lower Common Road SW15 1BP London | British | Chartered Accountant | 67271850002 | |||||
LEENDERS, Ilse | Director | 30 Baccara Grove Bletchley MK2 3AT Milton Keynes Buckinghamshire | British | I T Director | 71032040001 | |||||
LITTLEWOOD, John Nigel | Director | Mavins Court Greenhill Road GU9 8JN Farnham Surrey | British | Company Director | 13384060001 | |||||
MCCALLUM, Alexander James | Director | 28 Ouseley Road SW12 8EF London | United Kingdom | British | Accountant | 93679470001 | ||||
MOBBS, Andrew Graham | Director | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 100613070001 | ||||
MUSGRAVE HILL, Karen | Director | Abbey Farm Mitford NE61 2YN Morpeth Northumberland | British | Director | 48779830001 | |||||
PARBURY, Susanna Patricia | Director | 5 Earlsdon Avenue South Earlsdon CV5 6DU Coventry West Midlands | British | Managing Director | 33670410001 | |||||
PITT, Derek Neil | Director | 160 Shirehall Road DA2 7SN Hawley Kent | British | Sales Director | 14385530003 | |||||
RITCHIE, Garry | Director | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | United Kingdom | British | Director | 147482400001 | ||||
SEAR, Hugh Edward | Director | 1 Lynwood Avenue KT17 4LQ Epsom Surrey | England | English | Accountant | 47246600001 | ||||
SEWARD, Timothy Clifton | Director | Whiteposts 2 The Netherlands CR5 1ND Coulsdon Surrey | British | Director | 51783710001 | |||||
SPEAR, David John | Director | 12 Chatfield Road Cuckfield RH17 5BB Haywards Heath West Sussex | British | Director | 16030100001 | |||||
STRAKER, Jonathan | Director | 9 Campden Road CR2 7EQ South Croydon Surrey | British | Company Director | 10770260001 | |||||
WHITEWAY, Jeffrey Michael | Director | Unit 4 500 Purley Way CR0 4NZ Croydon Surrey | England | British | Director | 14385570002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Jonathan Paul Moulton | 06 abr 2016 | Buckingham Street WC2N 6DF London 10 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Guernsey | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Officezone Limited | 06 abr 2016 | Purley Way CR0 4NZ Croydon Unit 4 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 23 nov 2018 Entregado el 29 nov 2018 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 17 jul 2015 Entregado el 20 jul 2015 | Pendiente | ||
Breve descripción Not applicable. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 14 ago 2014 Entregado el 18 ago 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 24 jul 2014 Entregado el 08 ago 2014 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 24 jul 2014 Entregado el 08 ago 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 12 jun 2013 Entregado el 22 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 12 jun 2013 Entregado el 20 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Accession deed | Creado el 17 dic 2008 Entregado el 19 dic 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 abr 2003 Entregado el 10 abr 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 03 abr 2003 Entregado el 10 abr 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined) | Creado el 30 abr 2001 Entregado el 15 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee and debenture | Creado el 01 sept 1997 Entregado el 11 sept 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage deed | Creado el 26 nov 1988 Entregado el 14 dic 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £29,600 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción F/H 3 the boulevard balham high road london title nos sgl 24069 sgl 304952. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 05 ene 1988 Entregado el 12 ene 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security presented for registration in scotland on 4/10/85 | Creado el 13 sept 1985 Entregado el 15 oct 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £18,750 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee. | |
Breve descripción All & whole that dwellinghouse known as no 3 with courtyard attached in the development by holm farm homes limited being the southwestmost of 3 dwelling houses, formed or to be formed from part of northmost part of the range of buildings k/a mount melville steading mount melville, holmsfarm saint andrews, fife. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security registered at sasines on 16/7/85 | Creado el 10 jul 1985 Entregado el 18 jul 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Dwelling house k/a number three with courtyard attached in the development by holm farm homes limited at mount melville, st. Andrews, fife being the southwestmost of 3 dwelling houses formed or to be formed from part of the northmostpart of a range of buildings k/a mount melville steading mount melville holm farm, st. Andrews for details see doc M82. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene OFFICE TEAM LOGISTICS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0