H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED

H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaH.T.WEBB AND COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00575309
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    • Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos y aceites y grasas comestibles (46330) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 19 jun 2013

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 13 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 mar 2013

    Estado de capital el 25 mar 2013

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 13 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    12 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Jan Egtved Pedersen el 06 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Peter Lauritzen el 06 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Tanjot Soar el 06 dic 2010

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas225

    ¿Quiénes son los directivos de H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SOAR, Tanjot
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Secretario
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    British123350000001
    LAURITZEN, Peter
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Director
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanishChief Executive123354600001
    PEDERSEN, Jan Egtved
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    Director
    Arla House, 4 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Yorkshire
    EnglandDanishFinance Director123347470001
    BALL, Ute Suse
    60 Sycamore Drive
    LE6 0EW Groby
    Leicestershire
    Secretario
    60 Sycamore Drive
    LE6 0EW Groby
    Leicestershire
    British118371550001
    BANCROFT, Lynne Deborah
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    Secretario
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    BritishFinance Director70267830001
    JARVIS, Peter James
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    Secretario
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    British54493370001
    PRICE, John Philip
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    Secretario
    20 Rossmore Court
    Park Road
    NW1 6XX London
    British51592560002
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    Secretario
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    British74484590001
    REYNOLDS, Andrew David Finch
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    Secretario
    25 Franconia Road
    Clapham
    SW4 9NB London
    British63987530001
    YATES, Gordon
    3 Cornwallis Avenue
    CT6 6UQ Herne Bay
    Kent
    Secretario
    3 Cornwallis Avenue
    CT6 6UQ Herne Bay
    Kent
    British10502580001
    ALLIKER, Anthony John
    Treetops 508 Loose Road
    ME15 9UF Maidstone
    Kent
    Director
    Treetops 508 Loose Road
    ME15 9UF Maidstone
    Kent
    BritishDirector10502610001
    BANCROFT, Lynne Deborah
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    Director
    Playstole
    Chapel Lane Sissinghurst
    TN17 2JN Cranbrook
    Kent
    EnglandBritishFinance Director70267830001
    CHRISTIANSEN, Mikael
    Tarran Barn
    Hazelheads Lane
    HG5 0NX Knaresborough
    North Yorkshire
    Director
    Tarran Barn
    Hazelheads Lane
    HG5 0NX Knaresborough
    North Yorkshire
    DanishDirector89938470001
    CLARKE, Peter James
    21 Fennel Close
    Dickens Place
    ME1 1LW Rochester
    Kent
    Director
    21 Fennel Close
    Dickens Place
    ME1 1LW Rochester
    Kent
    BritishManaging Director91221920001
    DAVIDSON, Richard Colin Neil
    Maplewell Farm
    Maplewell Road
    LE12 8QY Woodhouse Eaves
    Leicestershire
    Director
    Maplewell Farm
    Maplewell Road
    LE12 8QY Woodhouse Eaves
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector And Dairyman110114680001
    EARPS, David Ian
    39 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JB Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    39 Dovedale Road
    West Bridgford
    NG2 6JB Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishOperations Director74248350001
    GILBERT, Martin James
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    10 Knowle Green
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director65655390002
    HEASMAN, Paul William
    7 Kesteven Close
    Halling
    ME2 1LZ Rochester
    Kent
    Director
    7 Kesteven Close
    Halling
    ME2 1LZ Rochester
    Kent
    BritishBuying Director82924260001
    INKPIN, Grant Roger
    Yew Tree House
    Wetherby Road
    LS22 4EP Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Yew Tree House
    Wetherby Road
    LS22 4EP Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector76825990001
    JARVIS, Peter James
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    Director
    184 Riddlesdown Road
    CR8 1DF Purley
    Surrey
    EnglandBritishAccountant54493370001
    JONES, Roger Francis
    8 Northbrook Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    Director
    8 Northbrook Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishOperations Director84336140001
    KIRKPATRICK, Peter John
    30 Ennerdale Drive
    Aughton
    L39 5HF Ormskirk
    Lancashire
    Director
    30 Ennerdale Drive
    Aughton
    L39 5HF Ormskirk
    Lancashire
    BritishCompany Director65033740001
    MORTENSEN, Ib
    Oak Beams
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    Director
    Oak Beams
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Kent
    DanishDirector92120800001
    PEET, Nigel David
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    Director
    49 Heworth Village
    YO31 1AE York
    United KingdomBritishDirector26623160002
    POPE, Charles Philip Torrington
    17 Festival Avenue
    DA3 7HR New Barn
    Kent
    Director
    17 Festival Avenue
    DA3 7HR New Barn
    Kent
    BritishOperations & Logistics Directo72399120001
    PRESTON, Frederick Alan
    Birchwood 73 Tunbury Avenue
    Walderslade
    ME5 9EJ Chatham
    Kent
    Director
    Birchwood 73 Tunbury Avenue
    Walderslade
    ME5 9EJ Chatham
    Kent
    BritishTechnical/Sales Director56295570001
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    Director
    The Old Forge
    Fall House Lane
    WF12 0NJ Dewsbury
    West Yorkshire
    BritishDirector74484590001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector111995510001
    SMITH, Timothy John
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    Director
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director84729640001
    VON MUHLENEN, Roger
    Ch-3186 Dudingen
    FOREIGN
    Switzerland
    Director
    Ch-3186 Dudingen
    FOREIGN
    Switzerland
    SwissCheese Producer10502620001
    WEBB, Anne Marie
    The Hermitage Les Maindonnaux
    St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    Director
    The Hermitage Les Maindonnaux
    St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    SwedishDirector9818800002
    WEBB, John Ernest
    The Hermitage
    Les Maindonnaux
    GY4 6AH St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    Director
    The Hermitage
    Les Maindonnaux
    GY4 6AH St Martin
    Guernsey
    Channel Islands
    BritishImporter9818790004

    ¿Tiene H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 04 nov 1998
    Entregado el 10 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 27 nov 1995
    Entregado el 14 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a land at springhead orchard springhead enterprise park northfleet kent with the goodwill of the business and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 14 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 oct 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 24 abr 1991
    Entregado el 26 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land at spring head enterprise park springhead road northfleet kent t/n k 696044 and assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 26 abr 1991Registro de una carga
    • 21 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 29 ago 1990
    Entregado el 04 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 04 sept 1990Registro de una carga
    • 29 oct 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 abr 1984
    Entregado el 19 abr 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £140,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Merchant Investors (Trustee Services) Limited
    • John Ernest Webb
    • Graham Paul Nicholls
    Transacciones
    • 19 abr 1984Registro de una carga
    • 26 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 mar 1980
    Entregado el 20 mar 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land & buildings 336 st james road, camberwell, london SE1.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank LTD
    Transacciones
    • 20 mar 1980Registro de una carga
    • 29 oct 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 03 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene H.T.WEBB AND COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 mar 2014Fecha de disolución
    19 jun 2013Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0