POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED

POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPOLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00576290
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Arterial Road
    SS15 6EE Laindon
    Essex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    W.PARKINSON & SON(OF BRADFORD)LIMITED27 dic 195627 dic 1956

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de Central Office Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW a Arterial Road Laindon Essex SS15 6EE el 05 sept 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    3 páginasAA

    Estado de capital el 15 jul 2019

    • Capital: GBP 2
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    As the company no longer had any assets or liabilities and did not trade, that pursuant to section 641 of the company act 2006, the company reduce it share to £2 and pursuant to section 610(4) of the companies act 2006 it share premium to nil 25/06/2019
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Clive Henry Bailey como director el 08 ago 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Corey Martin Macgillivray como director el 08 ago 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Lowe como director el 08 ago 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Stuart Edgar Foulds como director el 18 sept 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Glenn Hood como director el 18 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Paul Alexander Macniven como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael Peter Darnell como secretario el 26 jul 2016

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 20 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 dic 2015

    Estado de capital el 17 dic 2015

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Nombramiento de Mary Lucy Ransome como secretario el 29 sept 2015

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Stuart David Mustoe el 15 jul 2015

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DARNELL, Michael Peter
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    England
    Secretario
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    England
    212057000001
    RANSOME, Mary Lucy
    Newcomen Way, Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2 Charter Court
    Essex
    England
    Secretario
    Newcomen Way, Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2 Charter Court
    Essex
    England
    203536940001
    FOULDS, Stuart Edgar
    SS15 6EE Laindon
    Arterial Road
    Essex
    England
    Director
    SS15 6EE Laindon
    Arterial Road
    Essex
    England
    ScotlandBritish183160840001
    MUSTOE, Stuart David
    Charter Court, Newcomen Way
    Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    Essex
    England
    Director
    Charter Court, Newcomen Way
    Colchester Business Park
    CO4 9YA Colchester
    2
    Essex
    England
    EnglandBritish186382260001
    HUGHES, Graham Paul
    7 Sackville Close
    CM1 2LU Chelmsford
    Essex
    Secretario
    7 Sackville Close
    CM1 2LU Chelmsford
    Essex
    Other52315640002
    MACK, Lewis Bernard
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    British5774080001
    PAGE, Clive Charles
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    Secretario
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    British20963910001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Secretario corporativo
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ANDERSON, Ryan Jason
    Noak Hill Rd
    CM12 9UP Billericay
    252
    Essex
    England
    Director
    Noak Hill Rd
    CM12 9UP Billericay
    252
    Essex
    England
    EnglandUs Citizen133391500001
    BAILEY, Clive Henry
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    Director
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    EnglandBritish96018870001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Director
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BURGESS, Christopher Martin
    Rose Villas Main Street
    Sutton On The Forrest
    YO6 1DW York
    North Yorkshire
    Director
    Rose Villas Main Street
    Sutton On The Forrest
    YO6 1DW York
    North Yorkshire
    EnglandBritish5774090001
    CHECKLEY, Kenneth
    Thatched Cottage Leez Lane
    Hartford End
    CM3 1JP Chelmsford
    Essex
    Director
    Thatched Cottage Leez Lane
    Hartford End
    CM3 1JP Chelmsford
    Essex
    British11513480004
    COWPER, John Bernard
    3 Gilbey Green
    Newport
    CB11 3RS Saffron Walden
    Essex
    Director
    3 Gilbey Green
    Newport
    CB11 3RS Saffron Walden
    Essex
    British24251610001
    HAYDEN, Christopher William Roberts
    The Wilderness
    Pytches Road
    IP12 1EP Woodbridge
    Suffolk
    Director
    The Wilderness
    Pytches Road
    IP12 1EP Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish55991230008
    HOOD, Stephen Glenn
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Central Office
    Essex
    Director
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Central Office
    Essex
    UkBritish145363880001
    JACKSON, Eric
    Spring Grove House
    Clayton West
    HD8 9HH Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Spring Grove House
    Clayton West
    HD8 9HH Huddersfield
    West Yorkshire
    British5774100001
    JONES, Alun Morton
    Fen House
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Suffolk
    Director
    Fen House
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish12785600004
    KERR, Stuart Donald
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    Director
    Central Office
    Eagle Way
    CM13 3BW Brentwood
    Essex
    EnglandBritish186382100001
    KIERNAN, Paul Roger
    Willow Green
    CM4 0DQ Ingatestone
    41
    Essex
    England
    Director
    Willow Green
    CM4 0DQ Ingatestone
    41
    Essex
    England
    British133388000001
    LOWE, David
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1 447
    Essex
    England
    Director
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1 447
    Essex
    England
    EnglandBritish162848040001
    MACGILLIVRAY, Corey Martin
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    Director
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    United StatesAmerican158956920001
    MACK, Lewis Bernard
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    Director
    8 Crescent Gardens
    LS17 8DR Leeds
    West Yorkshire
    British5774080001
    MACNIVEN, Paul Alexander
    447 Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1
    Essex
    England
    Director
    447 Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1
    Essex
    England
    GermanyBritish181941880001
    MYERS, Bryan David
    Mevissenstrasse 16
    Cologne
    50668
    Germany
    Director
    Mevissenstrasse 16
    Cologne
    50668
    Germany
    British98436230001
    PARKER, Nigel Martin
    71a Wensleydale Road
    TW12 2LP Hampton
    Middlesex
    Director
    71a Wensleydale Road
    TW12 2LP Hampton
    Middlesex
    EnglandBritish41112840001
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Director
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Director
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    British22325820001
    STREETS, Harold
    Long Acre Green Lane
    Scawthorpe
    DN5 7UT Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    Long Acre Green Lane
    Scawthorpe
    DN5 7UT Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandEnglish19492250001
    THORLEY, David Ian
    14 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    Director
    14 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish97880070001
    TURNER, Mark C
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    Director
    Eagle Way
    Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    United KingdomAmerican161305720001
    WATKINS, Terry Christopher
    Heathercliffe Lodge
    Penistone
    S30 6FF Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Heathercliffe Lodge
    Penistone
    S30 6FF Sheffield
    South Yorkshire
    British5774110001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Director
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish54580940001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Director
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Canadian51303670001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Ford Retail Group Ltd
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    Trustford
    England
    06 abr 2016
    Charter Court, Newcomen Way
    Severalls Industrial Park
    CO4 9YA Colchester
    Trustford
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUk
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro950395
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene POLAR MOTOR COMPANY (BRADFORD) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A bulk deposit mortgage
    Creado el 04 ene 1993
    Entregado el 09 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies deposited from time to time by the co. With the chargee pursuant to a sor agreement dated 01.09.92.
    Personas con derecho
    • Ford Credit PLC
    Transacciones
    • 09 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from polar motor company (york) limited to the chargee on any acount whatsoever and by the mortgagor under te terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises land lying to the east of lumb lane bradford W. yorkshire t/n wyk 13808.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from polar motor company (york) limited to the chargee on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the chage.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises 78 and 80 bowland street bradford t/n wyk 15028.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from polar motor company (york) limited to the chargee on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands & hereditaments & premises:- 119 manningham lane bradford t/n wyk 85549.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises land off st judes place bradford and 52 and 56 to 72 (even nos.), 74 and 76, 67 and 69 all at bowland street bradford and 2 to 28 (even nos) elmsall street bradford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises st judes school st judes street bradford t/n wyk 11105.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises 111 manningham lane bradford t/n wyk 85543.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motot company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises being:- 121 manningham lane bradford t/n wyk 104611.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments and premises being:- 3-29 (odd nos.) st judes street bradford t/n wyk 104613.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments and premises being:- 125 manningham lane bradford t/n wyk 101742.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments and premises being:- land lying to the north east of st judes street bradford t/n wyk 97959.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments and premises being:- site of former parish church of st.judes manningham bradford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments and premises being:- 123 and 127 manningham lane bradford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgagor under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments and premises being:- land with workshop bowland street bradford and st judes place bradford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgage under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands herditaments & premises being:- dwelling houses and land 46 48 50 bowland street bradford st judes place and st judes square manningham bradford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgage under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises being:- 2-10 (even nos.) st.judes place bradford and 1, 3-10, and 12 st judes square, bradford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 07 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from polar motor company (york) limited to midland bank PLC on any account whatsoever and by the mortgage under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H lands hereditaments & premises being:- shops and office 113/117 manningham lane bradford and land at bowland street bradford.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 06 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 1987Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 31 dic 1984
    Entregado el 21 ene 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1) the benefit of all contracts for the hire of motor vehicles on conditional sale, lease or contract hire with ford credit 2) all right and title to the motor vehicles comprised in their security 3) all proceeds of sale & insurance monies recievable in respect of the assets comprised in this security.
    Personas con derecho
    • Ford Motor Credit Company
    Transacciones
    • 21 ene 1985Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 09 oct 1978
    Entregado el 13 oct 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the:- undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital. Shares, stocks and all other securities.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 1978Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 15 jun 1977
    Entregado el 27 jun 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies deposited from time to time with fons motor credit company LTD persuant to the terms of a sale or return agreement dated 1-9-74.
    Personas con derecho
    • Ford Motor Credit Company
    Transacciones
    • 27 jun 1977Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 may 1977
    Entregado el 09 jun 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1. f/h property known as comprising strip of land lying between the commercial workshops and st judes church off bowland street bradford. Described in statutory declaration dated 26 april 1977. (see doc M65) 2. site of former st jude's church bradford, west yorkshire. Title no wyk 97959.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 1977Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 may 1977
    Entregado el 09 jun 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property 3-29 (odd) st jude's street, bradford, west yorkshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 1977Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 may 1977
    Entregado el 08 jun 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the east of lumb lane, bradford, west yorkshire title no wyk 13808. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jun 1977Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 may 1977
    Entregado el 08 jun 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    78 and 80 bowland street bradford, west yorkshire title no. Wyk 15028. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jun 1977Registro de una carga
    • 02 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0