ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE

ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 00588263
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE?

    • (8010) /

    ¿Dónde se encuentra ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE?

    Dirección de la sede social
    7-9 The Avenue
    BN21 3YA Eastbourne
    East Sussex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ST. ANDREW'S SCHOOL TRUST (EASTBOURNE) LIMITED01 ago 195701 ago 1957

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta10 feb 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de 18 Hyde Gardens Eastbourne BN21 4PT el 15 jun 2011

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2011, aucune liste de membres fournie

    13 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 10 feb 2010

    25 páginasAA

    Nombramiento de Andrew Mark Robinson como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de David King como secretario

    2 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2010, aucune liste de membres fournie

    8 páginasAR01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 jul 2010 au 10 feb 2010

    3 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2009

    30 páginasAA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Memorándum y Estatutos

    25 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2008

    24 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2007

    24 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROBINSON, Andrew Mark
    52 Summerdown Road
    BN20 8DQ Eastbourne
    Kingscote
    East Sussex
    United Kingdom
    Secretario
    52 Summerdown Road
    BN20 8DQ Eastbourne
    Kingscote
    East Sussex
    United Kingdom
    British154203470001
    CATTO, Judith Mary
    Gun Road
    TN22 5HU Blackboys
    Shawford Farm
    E Sussex
    Director
    Gun Road
    TN22 5HU Blackboys
    Shawford Farm
    E Sussex
    British139215840001
    CORBETT, Andrew Stuart Reginald
    Holmewood House
    Barrow Lane, Langton Green
    TN3 0EB Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Holmewood House
    Barrow Lane, Langton Green
    TN3 0EB Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish47025430002
    DAVIES, Simon Philip
    The College
    Old Wish Road
    BN21 4JX Eastbourne
    East Sussex
    Director
    The College
    Old Wish Road
    BN21 4JX Eastbourne
    East Sussex
    EnglandBritish109682090001
    ECKERT, Nicola Lindsey
    Chalvington House
    Chalvington
    BN27 3TQ Hailsham
    East Sussex
    Director
    Chalvington House
    Chalvington
    BN27 3TQ Hailsham
    East Sussex
    United KingdomBritish40182290001
    EMSLIE, Alasdair John, Dr
    Green Lanes House
    Church Lane Hellingly
    BN27 4HA Hailsham
    East Sussex
    Director
    Green Lanes House
    Church Lane Hellingly
    BN27 4HA Hailsham
    East Sussex
    United KingdomBritish43251240001
    EVANS, Mark Roland
    Burleigh
    269 Kings Drive
    BN21 2UR Eastbourne
    Director
    Burleigh
    269 Kings Drive
    BN21 2UR Eastbourne
    United KingdomBritish79128550002
    EVERETT, Christopher Harris Doyle
    12 Madeira Park
    TN2 5SX Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    12 Madeira Park
    TN2 5SX Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish37783950001
    MCWALTER, Neil Crichton
    Field View
    Kingston Road
    BN7 3ND Lewes
    East Sussex
    Director
    Field View
    Kingston Road
    BN7 3ND Lewes
    East Sussex
    British99807920001
    ROBINSON, Andrew Mark
    Kingscote
    52 Summerdown Road
    BN20 8DQ Eastbourne
    East Sussex
    Director
    Kingscote
    52 Summerdown Road
    BN20 8DQ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritish50512800002
    SAUNDERS, Christopher John
    Folly Bottom
    Scottalls Lane, Hampstead Norreys
    RG18 0RT Thatcham
    Berkshire
    Director
    Folly Bottom
    Scottalls Lane, Hampstead Norreys
    RG18 0RT Thatcham
    Berkshire
    EnglandEnglish39121240004
    WOOLLIAMS, Mervyn Edwin
    Stone Cottage Peppering Eye
    TN33 0ST Battle
    East Sussex
    Director
    Stone Cottage Peppering Eye
    TN33 0ST Battle
    East Sussex
    EnglandBritish6710360002
    BISHOP, Wendy Frances
    76 Meads Street
    BN20 7RW Eastbourne
    East Sussex
    Secretario
    76 Meads Street
    BN20 7RW Eastbourne
    East Sussex
    British71315970001
    CLOSE, Thomas David
    9 Edensor Road
    BN20 7XR Eastbourne
    East Sussex
    Secretario
    9 Edensor Road
    BN20 7XR Eastbourne
    East Sussex
    British2603720001
    CRAWSHAW, John
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    Secretario
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    British121560001
    KING, David Richard
    82 Western Road
    BN7 1RP Lewes
    East Sussex
    Secretario
    82 Western Road
    BN7 1RP Lewes
    East Sussex
    British77948390002
    BARKER, Anne, Dame
    The Barn House
    Gatehouse Farm
    TN35 4HG Pett
    East Sussex
    Director
    The Barn House
    Gatehouse Farm
    TN35 4HG Pett
    East Sussex
    British6710370003
    BOWRON, Michael
    65 Sevenoaks Road
    TN15 8AR Borough Green
    Kent
    Director
    65 Sevenoaks Road
    TN15 8AR Borough Green
    Kent
    British83887610001
    BUSH, Charles Martin Peter
    Cobthorne
    West Street Oundle
    PE8 4EF Peterborough
    Director
    Cobthorne
    West Street Oundle
    PE8 4EF Peterborough
    United KingdomBritish108012680001
    CAFFYN, Ann Priscilla
    Four Acres
    98 Huggetts Lane Willingdon
    BN22 0LH Eastbourne
    East Sussex
    Director
    Four Acres
    98 Huggetts Lane Willingdon
    BN22 0LH Eastbourne
    East Sussex
    EnglandBritish6710300001
    COLLINS, Neil Adam
    12 Gertrude Street
    SW10 0JN London
    Director
    12 Gertrude Street
    SW10 0JN London
    EnglandBritish115908170001
    CRANSTON, Robert Ian
    Commandree The Street
    East Bergholt
    CO7 6SE Colchester
    Essex
    Director
    Commandree The Street
    East Bergholt
    CO7 6SE Colchester
    Essex
    EnglandBritish6710310001
    CRAWSHAW, John
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    Director
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritish121560001
    CRAWSHAW, John
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    Director
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritish121560001
    DEAN, Gordon Douglas
    10 Honeywood House
    28 Alington Road
    BH14 8LZ Poole
    Dorset
    Director
    10 Honeywood House
    28 Alington Road
    BH14 8LZ Poole
    Dorset
    EnglandBritish89496210001
    DURLACHER, William Patrick
    Whalebone House
    Langham
    CO4 5PX Colchester
    Essex
    Director
    Whalebone House
    Langham
    CO4 5PX Colchester
    Essex
    British6710330001
    FAIRCLOUGH, Ian Walter
    Merrow Farm
    Dunsfold
    GU8 4NX Godalming
    Surrey
    Director
    Merrow Farm
    Dunsfold
    GU8 4NX Godalming
    Surrey
    EnglandBritish6710340001
    HAYNES, Tanya
    5 Bolsover Road
    BN20 7JF Eastbourne
    East Sussex
    Director
    5 Bolsover Road
    BN20 7JF Eastbourne
    East Sussex
    British79407660001
    HOBAN, Brian Michael Stanislaw
    Upcot Wantage Road
    Streatley
    RG8 9LD Reading
    Berkshire
    Director
    Upcot Wantage Road
    Streatley
    RG8 9LD Reading
    Berkshire
    British6099150001
    LEE, Thomas Kang Bor
    3201 02 Alexandra House
    16 20 Charter Road Central
    FOREIGN Hong Kong
    Director
    3201 02 Alexandra House
    16 20 Charter Road Central
    FOREIGN Hong Kong
    British78682760002
    LONGLEY, Ann Rosamund
    Roedean School
    BN2 5RQ Brighton
    East Sussex
    Director
    Roedean School
    BN2 5RQ Brighton
    East Sussex
    British62241050001
    METHAM, Patricia
    Roedean House Roedean School
    BN2 5RQ Brighton
    East Sussex
    Director
    Roedean House Roedean School
    BN2 5RQ Brighton
    East Sussex
    British61467890001
    PICKETT, Thomas Raymond
    Park House Gooseberry Hall Lane
    Nonington
    CT15 4HJ Dover
    Kent
    Director
    Park House Gooseberry Hall Lane
    Nonington
    CT15 4HJ Dover
    Kent
    British12413800002
    RICHARDSON, Michael John De Rougement, Sir
    Butterstocks
    Shipley
    RH13 8PE Horsham
    West Sussex
    Director
    Butterstocks
    Shipley
    RH13 8PE Horsham
    West Sussex
    British69538490002
    SAUNDERS, Christopher John
    The Old Barn Barncroft Way
    AL1 5QZ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    The Old Barn Barncroft Way
    AL1 5QZ St Albans
    Hertfordshire
    British39121240003

    ¿Tiene ST. ANDREW'S SCHOOL, EASTBOURNE alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 30 ago 2006
    Entregado el 06 sept 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    St andrews school st andrews lodge and 74 to 84 meads street eastbourne east sussex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 sept 2006Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 07 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property known as st andrew's school st andrew's lodge and 74-80 meads street eastbourne east sussex t/n EB15581,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (395)
    Deed of security
    Creado el 29 mar 1978
    Entregado el 13 abr 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due not exceeding £100,000
    Breve descripción
    St. Andrew's school, st. Andrew's lodge and 74 to 80 (even numbers only) eastbourne, title no - eb 15581, floating charge on the (see doc M38 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Eastbourne College (Incorporated)
    Transacciones
    • 13 abr 1978Registro de una carga
    • 09 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Series of debentures
    Creado el 30 nov 1957
    Entregado el 09 dic 1957
    Satisfecho en su totalidad
    Transacciones
    • 09 dic 1957Registro de una carga
    • 09 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0