CORAM SHOWERS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CORAM SHOWERS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00589581 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CORAM SHOWERS LIMITED?
- Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra CORAM SHOWERS LIMITED?
Dirección de la sede social | Conquest Business Park Cad Rd TA19 9EA Ilton Somerset England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CORAM SHOWERS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
CORAM (UK) LIMITED | 22 may 1989 | 22 may 1989 |
TIGER HOME PRODUCTS LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
TIGER PLASTICS LIMITED | 29 ago 1957 | 29 ago 1957 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CORAM SHOWERS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CORAM SHOWERS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Kenneth Blackburn como director el 01 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Richard Huntly como director el 01 dic 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Alan Jarvis como director el 18 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Martin Hubbard como director el 18 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 20 dic 2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Building 3 Stanmore Industrial Estate Bridgnorth Shropshire WV15 5HP a Conquest Business Park Cad Rd Ilton Somerset TA19 9EA el 01 nov 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 005895810009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital el 16 ene 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 p áginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
¿Quiénes son los directivos de CORAM SHOWERS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIN, Mark | Secretario | Cad Rd TA19 9EA Ilton Conquest Business Park Somerset England | 160638930001 | |||||||
DAIN, Mark Richard | Director | Cad Rd TA19 9EA Ilton Conquest Business Park Somerset England | England | English | Accountant | 117343980001 | ||||
HUNTLY, Stephen Richard | Director | Cad Rd TA19 9EA Ilton Conquest Business Park Somerset England | England | British | Managing Director | 277651870001 | ||||
BEAVER, Carl Michael | Secretario | 38 Crown Mews PR4 2HW Kirkham Preston Lancashire | British | 75798840001 | ||||||
BURDEN, Dennis Gordon | Secretario | 28a Oxley Moor Road Oxley WV10 6TU Wolverhampton West Midlands | British | Director | 22930280001 | |||||
BURDEN, Dennis Gordon | Secretario | 28a Oxley Moor Road Oxley WV10 6TU Wolverhampton West Midlands | British | Director | 22930280001 | |||||
CASSON, Howard Stanley | Secretario | 27 Victoria Road Fulwood PR2 8NE Preston Lancashire | British | 2188030001 | ||||||
DHADWAR, Tersam Singh | Secretario | The Hayloft Betton Mews Betton Strange SY5 6JA Shrewsbury | British | 62512360001 | ||||||
DONALD, Andrew David Livingstone | Secretario | 22 Boughey Road TF10 7QF Newport Shropshire | British | Accountant | 41075700001 | |||||
ENSOR, Victor John | Secretario | 42 Malvern Avenue CV10 8ND Nuneaton Warwickshire | British | Financial Director | 11682760001 | |||||
JONES, Gary | Secretario | 70 Bassnage Road B63 4HG Halesowen West Midlands | British | 39277830002 | ||||||
BLACKBURN, John Kenneth | Director | Cad Rd TA19 9EA Ilton Conquest Business Park Somerset England | England | British | Director | 113390120001 | ||||
BURDEN, Dennis Gordon | Director | 4 Wren Avenue Perton WV6 7TS Wolverhampton | British | Director | 22930280003 | |||||
CAMPBELL, Gary David | Director | 9 Kingfisher Way Lee Somery TF1 4FW Telford Salop | British | Sales Director | 37820030001 | |||||
CASSON, Howard Stanley | Director | 27 Victoria Road Fulwood PR2 8NE Preston Lancashire | British | Chartered Accountant | 2188030001 | |||||
DIMELOE, Peter William | Director | 8 Ashmole Close WS14 9RS Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | Managing Director | 36078950001 | ||||
DONALD, Andrew David Livingstone | Director | 22 Boughey Road TF10 7QF Newport Shropshire | British | Accountant | 41075700001 | |||||
ENSOR, Victor John | Director | 42 Malvern Avenue CV10 8ND Nuneaton Warwickshire | British | Financial Director | 11682760001 | |||||
GRANT, Adrian Charles James | Director | Gate Cottage 98 Headroom Gate Road FY8 1UR St Annes On Sea Lancs | England | British | Company Director | 32966050002 | ||||
HOBBS, Charles Geoffrey | Director | Holly Cottage Outwoods TF10 9DZ Newport Salop | British | Managing Director | 25542050003 | |||||
HUBBARD, Steven Martin | Director | Woodford Way WV5 8HE Wombourne 9 South Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 131620000001 | ||||
JARVIS, Robert Alan | Director | Golf Links Lane TF1 2DT Wellington 22 Shropshire | England | British | Technical Director | 131619900001 | ||||
KAINTH, Sushil | Director | 257 Broadway North WS1 2PS Walsall West Midlands | United Kingdom | British | Technical Director | 9890990002 | ||||
MCCORMICK, Keith | Director | 8 Bencroft Close DE65 5WB Hilton Derbyshire | United Kingdom | British | Sales Director | 89897960001 | ||||
NICHOLSON, Robert | Director | 184 St Davids Road North FY8 2DJ Lytham St Annes Lancashire | British | Director | 2188040002 | |||||
PILAAR, Niels Jan | Director | Schooliaan 5 NL1906 Ae Limmen Netherlands | Netherlands | Dutch | Director | 58162960002 | ||||
VAN KEMPEN, Arnoldus Henricus Joannes Maria | Director | Laarbroek 10 FOREIGN 5721 Wl Asten Holland | Dutch | Director | 23411200001 | |||||
VAN KEMPEN, Christianus Henrikus Joannes Maria | Director | Suylke 23 5731ch Midalo Holland | Dutch | Director | 24717730001 | |||||
VAN KEMPEN, Harrie | Director | Tisselrietwee 9 FOREIGN 3580 Neerpelt Belgium | Dutch | Director | 24717720001 | |||||
VAN KEMPEN, Josephus Geraldus Joannes Maria | Director | Dennenstraat 10 3590 Achel Belguim | Dutch | Director | 23411190001 | |||||
WILDING, Sally Ann | Director | 5 Meerhill Avenue Shirley B90 4TU Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 38846080001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CORAM SHOWERS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coram Uk Holding Ltd | 06 abr 2016 | Stanmore Industrial Estate WV15 5HP Bridgnorth Building 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CORAM SHOWERS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 17 dic 2014 Entregado el 02 ene 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Twelve trademarks being UK00001314990, UK00001314991, UK00001491135, UK00001538188, UK00002067388, UK00002067389, UK00002067393, UK00002123484, UK00002140035, UK00002465765, UK00002349832, UK00002467975. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 20 mar 2013 Entregado el 05 abr 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or any of the other borrowers to the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of fixed charge all the debts, any deposits, margins, commissions or other rights, all loan capital, indebtedness or liabilities, the contracts and by way of floating charge all the stock-in-trade see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts | Creado el 06 oct 1997 Entregado el 09 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under an invoice discounting agreement or otherwise | |
Breve descripción Fixed and floating charge on all debts the subject of the invoice discounting agreement. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture deed | Creado el 19 sept 1997 Entregado el 23 sept 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee and debenture | Creado el 08 feb 1994 Entregado el 18 feb 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or laconite plastics limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 08 ene 1990 Entregado el 15 ene 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land & buildings on south side of scafell road lytham st annes lancashire title no la 416021. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 12 abr 1983 Entregado el 25 abr 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land on the south side of scafall road, lytham st annes, lancashire. Title no la 416021. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 25 sept 1978 Entregado el 28 sept 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Plot of land situate on south side of scafell road kilnhouse lane industrial estate st. Annes-on-sea lancashire la 416021. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Time limit extended by order of court 15/01/74 | Creado el 19 sept 1972 Entregado el 28 ene 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing £9,520 | |
Breve descripción Land on the east side of copse road, fleetwood lancs. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0