CORAM SHOWERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCORAM SHOWERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00589581
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CORAM SHOWERS LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CORAM SHOWERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Conquest Business Park
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Somerset
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CORAM SHOWERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CORAM (UK) LIMITED22 may 198922 may 1989
    TIGER HOME PRODUCTS LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    TIGER PLASTICS LIMITED29 ago 195729 ago 1957

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CORAM SHOWERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CORAM SHOWERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cese del nombramiento de John Kenneth Blackburn como director el 01 dic 2020

    1 páginasTM01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Stephen Richard Huntly como director el 01 dic 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Robert Alan Jarvis como director el 18 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven Martin Hubbard como director el 18 dic 2019

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 20 dic 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Domicilio social registrado cambiado de Building 3 Stanmore Industrial Estate Bridgnorth Shropshire WV15 5HP a Conquest Business Park Cad Rd Ilton Somerset TA19 9EA el 01 nov 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    23 páginasAA

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cancelación total de la carga 005895810009

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    2 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital el 16 ene 2018

    • Capital: GBP 2,289,494
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    ¿Quiénes son los directivos de CORAM SHOWERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAIN, Mark
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Secretario
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    160638930001
    DAIN, Mark Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Director
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandEnglishAccountant117343980001
    HUNTLY, Stephen Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Director
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritishManaging Director277651870001
    BEAVER, Carl Michael
    38 Crown Mews
    PR4 2HW Kirkham Preston
    Lancashire
    Secretario
    38 Crown Mews
    PR4 2HW Kirkham Preston
    Lancashire
    British75798840001
    BURDEN, Dennis Gordon
    28a Oxley Moor Road
    Oxley
    WV10 6TU Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    28a Oxley Moor Road
    Oxley
    WV10 6TU Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector22930280001
    BURDEN, Dennis Gordon
    28a Oxley Moor Road
    Oxley
    WV10 6TU Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    28a Oxley Moor Road
    Oxley
    WV10 6TU Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector22930280001
    CASSON, Howard Stanley
    27 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 8NE Preston
    Lancashire
    Secretario
    27 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 8NE Preston
    Lancashire
    British2188030001
    DHADWAR, Tersam Singh
    The Hayloft Betton Mews
    Betton Strange
    SY5 6JA Shrewsbury
    Secretario
    The Hayloft Betton Mews
    Betton Strange
    SY5 6JA Shrewsbury
    British62512360001
    DONALD, Andrew David Livingstone
    22 Boughey Road
    TF10 7QF Newport
    Shropshire
    Secretario
    22 Boughey Road
    TF10 7QF Newport
    Shropshire
    BritishAccountant41075700001
    ENSOR, Victor John
    42 Malvern Avenue
    CV10 8ND Nuneaton
    Warwickshire
    Secretario
    42 Malvern Avenue
    CV10 8ND Nuneaton
    Warwickshire
    BritishFinancial Director11682760001
    JONES, Gary
    70 Bassnage Road
    B63 4HG Halesowen
    West Midlands
    Secretario
    70 Bassnage Road
    B63 4HG Halesowen
    West Midlands
    British39277830002
    BLACKBURN, John Kenneth
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Director
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritishDirector113390120001
    BURDEN, Dennis Gordon
    4 Wren Avenue
    Perton
    WV6 7TS Wolverhampton
    Director
    4 Wren Avenue
    Perton
    WV6 7TS Wolverhampton
    BritishDirector22930280003
    CAMPBELL, Gary David
    9 Kingfisher Way
    Lee Somery
    TF1 4FW Telford
    Salop
    Director
    9 Kingfisher Way
    Lee Somery
    TF1 4FW Telford
    Salop
    BritishSales Director37820030001
    CASSON, Howard Stanley
    27 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 8NE Preston
    Lancashire
    Director
    27 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 8NE Preston
    Lancashire
    BritishChartered Accountant2188030001
    DIMELOE, Peter William
    8 Ashmole Close
    WS14 9RS Lichfield
    Staffordshire
    Director
    8 Ashmole Close
    WS14 9RS Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritishManaging Director36078950001
    DONALD, Andrew David Livingstone
    22 Boughey Road
    TF10 7QF Newport
    Shropshire
    Director
    22 Boughey Road
    TF10 7QF Newport
    Shropshire
    BritishAccountant41075700001
    ENSOR, Victor John
    42 Malvern Avenue
    CV10 8ND Nuneaton
    Warwickshire
    Director
    42 Malvern Avenue
    CV10 8ND Nuneaton
    Warwickshire
    BritishFinancial Director11682760001
    GRANT, Adrian Charles James
    Gate Cottage
    98 Headroom Gate Road
    FY8 1UR St Annes On Sea
    Lancs
    Director
    Gate Cottage
    98 Headroom Gate Road
    FY8 1UR St Annes On Sea
    Lancs
    EnglandBritishCompany Director32966050002
    HOBBS, Charles Geoffrey
    Holly Cottage
    Outwoods
    TF10 9DZ Newport
    Salop
    Director
    Holly Cottage
    Outwoods
    TF10 9DZ Newport
    Salop
    BritishManaging Director25542050003
    HUBBARD, Steven Martin
    Woodford Way
    WV5 8HE Wombourne
    9
    South Staffordshire
    Director
    Woodford Way
    WV5 8HE Wombourne
    9
    South Staffordshire
    United KingdomBritishDirector131620000001
    JARVIS, Robert Alan
    Golf Links Lane
    TF1 2DT Wellington
    22
    Shropshire
    Director
    Golf Links Lane
    TF1 2DT Wellington
    22
    Shropshire
    EnglandBritishTechnical Director131619900001
    KAINTH, Sushil
    257 Broadway North
    WS1 2PS Walsall
    West Midlands
    Director
    257 Broadway North
    WS1 2PS Walsall
    West Midlands
    United KingdomBritishTechnical Director9890990002
    MCCORMICK, Keith
    8 Bencroft Close
    DE65 5WB Hilton
    Derbyshire
    Director
    8 Bencroft Close
    DE65 5WB Hilton
    Derbyshire
    United KingdomBritishSales Director89897960001
    NICHOLSON, Robert
    184 St Davids Road North
    FY8 2DJ Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    184 St Davids Road North
    FY8 2DJ Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishDirector2188040002
    PILAAR, Niels Jan
    Schooliaan 5
    NL1906 Ae Limmen
    Netherlands
    Director
    Schooliaan 5
    NL1906 Ae Limmen
    Netherlands
    NetherlandsDutchDirector58162960002
    VAN KEMPEN, Arnoldus Henricus Joannes Maria
    Laarbroek 10
    FOREIGN 5721 Wl Asten
    Holland
    Director
    Laarbroek 10
    FOREIGN 5721 Wl Asten
    Holland
    DutchDirector23411200001
    VAN KEMPEN, Christianus Henrikus Joannes Maria
    Suylke 23
    5731ch Midalo
    Holland
    Director
    Suylke 23
    5731ch Midalo
    Holland
    DutchDirector24717730001
    VAN KEMPEN, Harrie
    Tisselrietwee 9
    FOREIGN 3580 Neerpelt
    Belgium
    Director
    Tisselrietwee 9
    FOREIGN 3580 Neerpelt
    Belgium
    DutchDirector24717720001
    VAN KEMPEN, Josephus Geraldus Joannes Maria
    Dennenstraat 10
    3590 Achel
    Belguim
    Director
    Dennenstraat 10
    3590 Achel
    Belguim
    DutchDirector23411190001
    WILDING, Sally Ann
    5 Meerhill Avenue
    Shirley
    B90 4TU Solihull
    West Midlands
    Director
    5 Meerhill Avenue
    Shirley
    B90 4TU Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant38846080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CORAM SHOWERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Coram Uk Holding Ltd
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 1
    England
    06 abr 2016
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 1
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Shares Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro07214057
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene CORAM SHOWERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2014
    Entregado el 02 ene 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Twelve trademarks being UK00001314990, UK00001314991, UK00001491135, UK00001538188, UK00002067388, UK00002067389, UK00002067393, UK00002123484, UK00002140035, UK00002465765, UK00002349832, UK00002467975.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transacciones
    • 02 ene 2015Registro de una carga (MR01)
    • 04 ene 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 20 mar 2013
    Entregado el 05 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other borrowers to the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge all the debts, any deposits, margins, commissions or other rights, all loan capital, indebtedness or liabilities, the contracts and by way of floating charge all the stock-in-trade see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. and Abn Amro Bank N.V.
    Transacciones
    • 05 abr 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 12 dic 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts
    Creado el 06 oct 1997
    Entregado el 09 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an invoice discounting agreement or otherwise
    Breve descripción
    Fixed and floating charge on all debts the subject of the invoice discounting agreement.
    Personas con derecho
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transacciones
    • 09 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 24 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 19 sept 1997
    Entregado el 23 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 08 feb 1994
    Entregado el 18 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or laconite plastics limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 ene 1990
    Entregado el 15 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings on south side of scafell road lytham st annes lancashire title no la 416021.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ene 1990Registro de una carga
    • 24 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 abr 1983
    Entregado el 25 abr 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land on the south side of scafall road, lytham st annes, lancashire. Title no la 416021.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 abr 1983Registro de una carga
    • 24 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 25 sept 1978
    Entregado el 28 sept 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plot of land situate on south side of scafell road kilnhouse lane industrial estate st. Annes-on-sea lancashire la 416021. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Algemene Bank Nederland N.V.
    Transacciones
    • 28 sept 1978Registro de una carga
    • 24 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Time limit extended by order of court 15/01/74
    Creado el 19 sept 1972
    Entregado el 28 ene 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £9,520
    Breve descripción
    Land on the east side of copse road, fleetwood lancs.
    Personas con derecho
    • Maritime Industrial Estates LTD
    Transacciones
    • 28 ene 1974Registro de una carga
    • 24 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0