CARILLION CONSTRUCTION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARILLION CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00594581 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
¿Dónde se encuentra CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TARMAC CONSTRUCTION LIMITED | 29 nov 1957 | 29 nov 1957 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2017 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2018 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 may 2018 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 may 2018 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 may 2017 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 6 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Domicilio social registrado cambiado de , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 17 jul 2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 3 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Modification des détails de Carillion Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 01 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 10 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 21 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 27 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 27 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 15 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 39 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 33 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 15 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 13 páginas | NDISC | ||
¿Quiénes son los directivos de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITZHUGH, Dirk Olaf | Secretario | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183600001 | |||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Secretario | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Secretario | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BAKER, Bryan William | Director | Little Hales House Chetwynd Aston TF10 9AW Newport Shropshire | British | 12567920001 | ||||||
| BOORMAN, Derek, Sir | Director | Lower Rowling Goodnestone CT3 1QA Canterbury Kent | British | 62319660001 | ||||||
| BOOTH, Karen Jane | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| BOYES, Brian Chester | Director | Border Close The Crescent Woodlands Road Ashurst SO40 7AQ Southampton Hants | British | 11609460003 | ||||||
| BRYDEN, Gordon | Director | 20 Dumville Drive RH9 8NY Godstone Surrey | British | 53913100004 | ||||||
| GELSTON, John Richard | Director | 12 Longbridge Road WS14 9AL Lichfield Staffordshire | British | 9996190001 | ||||||
| GEORGEL, Brian | Director | Le Groeg 54 Clifton Road Tettenhall WV6 9AP Wolverhampton West Midlands | British | 8675730001 | ||||||
| GILL, Matthew Clement Hugh | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 160968480002 | |||||
| GIRLING, Christopher Francis | Director | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| GREEN, Adam Richard | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 129918780001 | |||||
| HAYWARD, Alan | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HERZBERG, Francis Robin | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 52429400001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| HURCOMB, David Stuart | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 34516340004 | |||||
| KENNEDY, Francis Milne | Director | Aughton 36 St Albans Road RH2 9LN Reigate Surrey | British | 3792110001 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| KIRK, Paul Robert | Director | 4 Beauchamp Gardens Myton Lane CV34 6QG Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 29144870002 | |||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Director | 153 Sneyd Lane Essington WV11 2DX Wolverhampton | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| LUMBY, Richard Gregg | Director | Yew Tree House West Felton SY11 4EQ Oswestry Shropshire | England | British | 65529640001 | |||||
| MASON, Terence Harold | Director | Stratton Court Long Common WV5 7AX Claverley Shropshire | England | British | 3741500002 | |||||
| MCDONOUGH, John | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| MCEWAN, Euan | Director | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| MERCER, Emma Louise | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 163383420001 | |||||
| MILLS, Lee James | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| MOORE, John | Director | 23 Hollington Way B90 4YD Solihull West Midlands | British | 84441190001 | ||||||
| MYATT, Christopher John | Director | High Clere 166 Oulton Road ST15 8DR Stone Staffordshire | England | British | 649790001 | |||||
| OSBORNE, Alan | Director | Windtridge 30 Ludlow Road WV16 5AF Bridgnorth Salop | England | British | 108956240001 | |||||
| PALMER, Martyn Charles | Director | Woodlands Church End, Bishampton WR10 2LT Pershore Worcestershire | United Kingdom | British | 203408350001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Plc | 06 abr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CARILLION CONSTRUCTION LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 09 dic 2016 Entregado el 16 dic 2016 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 26 jul 2011 Entregado el 29 jul 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 13 dic 2007 Entregado el 15 dic 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £17,625.00 due or to become due from the company to | |
Breve descripción The rent deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 22 nov 2007 Entregado el 28 nov 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £17,037.50 due or to become due from the company to | |
Breve descripción Rent deposit of £17,037.50. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 22 nov 2007 Entregado el 28 nov 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £4,406.25 due or to become due from the company to | |
Breve descripción Rent deposit of £4,406.25. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 26 ene 2007 Entregado el 31 ene 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 30 jul 2002 Entregado el 06 ago 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The interest of the company in the account (as defined in the rent deposit deed). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over shares | Creado el 23 ago 1999 Entregado el 07 sept 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined | |
Breve descripción By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over shares | Creado el 23 ago 1999 Entregado el 07 sept 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined | |
Breve descripción By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over shares | Creado el 24 dic 1997 Entregado el 07 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee to pay the success fee and/or observe its obligations under the guarantee and additional fee agreement dated 24 december 1997 | |
Breve descripción All present and future shares of baa-mcarthur/glen (mansfield) limited and/or baa-mcarthur/glen (swindon) limited and baa-mcarthur/glen (bridgend) limitedheld by or on behalf of the company and all dividends bonuses options etc in relation thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit deed | Creado el 19 oct 1994 Entregado el 21 oct 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 12TH september 1994 and a licence for alterations dated 19TH october 1994 | |
Breve descripción The sum of £2,000 deposited by the company with the chargee in accordance with the terms of the deed and any interest accrued thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security deposit agreement | Creado el 21 feb 1994 Entregado el 24 feb 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein acting together in a joint venture as translink joint venture to the chargee under the terms of a lease dated 21ST february 1994 and this agreement | |
Breve descripción The sum of £20,000 and all interest earned thereon deposited under the terms of the security deposit deed dated 21ST february 1994. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed | Creado el 26 jun 1972 Entregado el 07 jul 1972 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £2,750,000 | |
Breve descripción By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed | Creado el 16 dic 1968 Entregado el 16 dic 1968 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Third supplemental trust deed securing debenture stock of tarmac derby LTD amounting to £7,652,725 inclusive of £5,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 and deeds supplemental thereto | |
Breve descripción First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Second supplemental trust deed | Creado el 17 jul 1967 Entregado el 17 jul 1967 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Second supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £5,000,000 inclusive of £3,000,000 secured by two deeds dated 05/10/64 & 26/10/65 respectively | |
Breve descripción By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed | Creado el 26 oct 1965 Entregado el 09 nov 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £3,000,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 | |
Breve descripción First floating charge by way of security for the repayment by tarmac LTD of the debenture stock mentioned in col.3 On the undertaking of the company and all its property and assets both present and future (including uncalled capital). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 05 oct 1964 Entregado el 04 oct 1964 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £2,000,000 debenture stock of tarmac LTD | |
Breve descripción First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CARILLION CONSTRUCTION LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0