CARILLION CONSTRUCTION LIMITED

CARILLION CONSTRUCTION LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARILLION CONSTRUCTION LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00594581
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pwc 8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TARMAC CONSTRUCTION LIMITED29 nov 195729 nov 1957

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2017
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2018
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta07 may 2018
    Próxima declaración de confirmación vence21 may 2018
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta07 may 2017
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    6 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Domicilio social registrado cambiado de , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 17 jul 2019

    2 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    3 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Modification des détails de Carillion Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 01 oct 2018

    1 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    10 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    21 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    27 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    27 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    15 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    39 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    33 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    15 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    13 páginasNDISC

    ¿Quiénes son los directivos de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FITZHUGH, Dirk Olaf
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    Secretario
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    British612090001
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    MAFFEI, Westley
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    235183600001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Secretario
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    British678610003
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Secretario
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    BAKER, Bryan William
    Little Hales House
    Chetwynd Aston
    TF10 9AW Newport
    Shropshire
    Director
    Little Hales House
    Chetwynd Aston
    TF10 9AW Newport
    Shropshire
    British12567920001
    BOORMAN, Derek, Sir
    Lower Rowling Goodnestone
    CT3 1QA Canterbury
    Kent
    Director
    Lower Rowling Goodnestone
    CT3 1QA Canterbury
    Kent
    British62319660001
    BOOTH, Karen Jane
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish192636860001
    BOYES, Brian Chester
    Border Close The Crescent
    Woodlands Road Ashurst
    SO40 7AQ Southampton
    Hants
    Director
    Border Close The Crescent
    Woodlands Road Ashurst
    SO40 7AQ Southampton
    Hants
    British11609460003
    BRYDEN, Gordon
    20 Dumville Drive
    RH9 8NY Godstone
    Surrey
    Director
    20 Dumville Drive
    RH9 8NY Godstone
    Surrey
    British53913100004
    GELSTON, John Richard
    12 Longbridge Road
    WS14 9AL Lichfield
    Staffordshire
    Director
    12 Longbridge Road
    WS14 9AL Lichfield
    Staffordshire
    British9996190001
    GEORGEL, Brian
    Le Groeg 54 Clifton Road
    Tettenhall
    WV6 9AP Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Le Groeg 54 Clifton Road
    Tettenhall
    WV6 9AP Wolverhampton
    West Midlands
    British8675730001
    GILL, Matthew Clement Hugh
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandBritish160968480002
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Director
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    GREEN, Adam Richard
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish129918780001
    HAYWARD, Alan
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish154549030001
    HERZBERG, Francis Robin
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish52429400001
    HOWSON, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish147650310001
    HURCOMB, David Stuart
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish34516340004
    KENNEDY, Francis Milne
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    Director
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    British3792110001
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    KIRK, Paul Robert
    4 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    Director
    4 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish29144870002
    LEDWIDGE, Joseph John
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    Director
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    United KingdomBritish105384920001
    LUMBY, Richard Gregg
    Yew Tree House
    West Felton
    SY11 4EQ Oswestry
    Shropshire
    Director
    Yew Tree House
    West Felton
    SY11 4EQ Oswestry
    Shropshire
    EnglandBritish65529640001
    MASON, Terence Harold
    Stratton Court
    Long Common
    WV5 7AX Claverley
    Shropshire
    Director
    Stratton Court
    Long Common
    WV5 7AX Claverley
    Shropshire
    EnglandBritish3741500002
    MCDONOUGH, John
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    UkBritish74536340007
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Director
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    MERCER, Emma Louise
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandBritish163383420001
    MILLS, Lee James
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish53951880001
    MOORE, John
    23 Hollington Way
    B90 4YD Solihull
    West Midlands
    Director
    23 Hollington Way
    B90 4YD Solihull
    West Midlands
    British84441190001
    MYATT, Christopher John
    High Clere 166 Oulton Road
    ST15 8DR Stone
    Staffordshire
    Director
    High Clere 166 Oulton Road
    ST15 8DR Stone
    Staffordshire
    EnglandBritish649790001
    OSBORNE, Alan
    Windtridge
    30 Ludlow Road
    WV16 5AF Bridgnorth
    Salop
    Director
    Windtridge
    30 Ludlow Road
    WV16 5AF Bridgnorth
    Salop
    EnglandBritish108956240001
    PALMER, Martyn Charles
    Woodlands
    Church End, Bishampton
    WR10 2LT Pershore
    Worcestershire
    Director
    Woodlands
    Church End, Bishampton
    WR10 2LT Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritish203408350001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3782379
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CARILLION CONSTRUCTION LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 09 dic 2016
    Entregado el 16 dic 2016
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 16 dic 2016Registro de una carga (MR01)
    Rent deposit deed
    Creado el 26 jul 2011
    Entregado el 29 jul 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account see image for full details.
    Personas con derecho
    • Elizabeth Property Nominee (No.3) Limited and Elizabeth Property Nominee (No.4) Limited as Trustees for the Elizabeth House Limited Partnership
    Transacciones
    • 29 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    Rent deposit deed
    Creado el 13 dic 2007
    Entregado el 15 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £17,625.00 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    The rent deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Howard Lewisham Limited
    Transacciones
    • 15 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 22 nov 2007
    Entregado el 28 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £17,037.50 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    Rent deposit of £17,037.50.
    Personas con derecho
    • Howard Lewisham Limited
    Transacciones
    • 28 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 22 nov 2007
    Entregado el 28 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £4,406.25 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    Rent deposit of £4,406.25.
    Personas con derecho
    • Howard Lewisham Limited
    Transacciones
    • 28 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 26 ene 2007
    Entregado el 31 ene 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • P & O Property Holdings Limited
    Transacciones
    • 31 ene 2007Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 30 jul 2002
    Entregado el 06 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest of the company in the account (as defined in the rent deposit deed).
    Personas con derecho
    • Robert Edward Gunn and Lynne Teresa Peacock
    Transacciones
    • 06 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 23 ago 1999
    Entregado el 07 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 23 ago 1999
    Entregado el 07 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 24 dic 1997
    Entregado el 07 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee to pay the success fee and/or observe its obligations under the guarantee and additional fee agreement dated 24 december 1997
    Breve descripción
    All present and future shares of baa-mcarthur/glen (mansfield) limited and/or baa-mcarthur/glen (swindon) limited and baa-mcarthur/glen (bridgend) limitedheld by or on behalf of the company and all dividends bonuses options etc in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit deed
    Creado el 19 oct 1994
    Entregado el 21 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 12TH september 1994 and a licence for alterations dated 19TH october 1994
    Breve descripción
    The sum of £2,000 deposited by the company with the chargee in accordance with the terms of the deed and any interest accrued thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mark Charles Batten
    • John Francis Soden
    Transacciones
    • 21 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security deposit agreement
    Creado el 21 feb 1994
    Entregado el 24 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein acting together in a joint venture as translink joint venture to the chargee under the terms of a lease dated 21ST february 1994 and this agreement
    Breve descripción
    The sum of £20,000 and all interest earned thereon deposited under the terms of the security deposit deed dated 21ST february 1994. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Sencara Properties Limited
    Transacciones
    • 24 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creado el 26 jun 1972
    Entregado el 07 jul 1972
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £2,750,000
    Breve descripción
    By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transacciones
    • 07 jul 1972Registro de una carga
    • 05 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creado el 16 dic 1968
    Entregado el 16 dic 1968
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Third supplemental trust deed securing debenture stock of tarmac derby LTD amounting to £7,652,725 inclusive of £5,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 and deeds supplemental thereto
    Breve descripción
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transacciones
    • 16 dic 1968Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creado el 17 jul 1967
    Entregado el 17 jul 1967
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Second supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £5,000,000 inclusive of £3,000,000 secured by two deeds dated 05/10/64 & 26/10/65 respectively
    Breve descripción
    By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transacciones
    • 17 jul 1967Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creado el 26 oct 1965
    Entregado el 09 nov 1965
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £3,000,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64
    Breve descripción
    First floating charge by way of security for the repayment by tarmac LTD of the debenture stock mentioned in col.3 On the undertaking of the company and all its property and assets both present and future (including uncalled capital).
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transacciones
    • 09 nov 1965Registro de una carga
    • 05 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 05 oct 1964
    Entregado el 04 oct 1964
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £2,000,000 debenture stock of tarmac LTD
    Breve descripción
    First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transacciones
    • 04 oct 1964Registro de una carga
    • 05 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CARILLION CONSTRUCTION LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 ene 2018Fecha de la petición
    15 ene 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profesional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0