ENVOPAK GROUP

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENVOPAK GROUP
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 00596706
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENVOPAK GROUP?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ENVOPAK GROUP?

    Dirección de la sede social
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENVOPAK GROUP?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ENVOPAK LIMITED08 ene 195808 ene 1958

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENVOPAK GROUP?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENVOPAK GROUP?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    3 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 nov 2011 au 31 dic 2011

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 nov 2011

    Estado de capital el 30 nov 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2010

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2009

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ola Tricia Aramita Barreto-Morley el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Philip Matthew Deakin el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Edward Ufland el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Giles Hudson el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario S & J Registrars Limited el 01 oct 2009

    2 páginasCH04

    Cese del nombramiento de Gavin Udall como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Philip Matthew Deakin como director

    2 páginasAP01

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2008

    3 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2007

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2006

    3 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de ENVOPAK GROUP?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01740543
    43122090005
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Director
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Director
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Director
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Director
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish87558180001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Secretario
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    PIPER, Maurice George
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    Secretario
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    British8141120001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Secretario
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    WICKETT, Edna May
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    Secretario
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    British36891520001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Secretario
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001
    ARTHUR, Frank Henry
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    Director
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    EnglandBritish8141130001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Director
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Director
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    Director
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    British73554610001
    CAMERON, Ian Donald
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    Director
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    British13521010001
    HENSHAW, Robert Charles Mayon
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    Director
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    British66661330001
    HOLLINGSWORTH, Roger Colin
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    Director
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    British20963700001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Director
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    KIRBY, Robert Bernard
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    Director
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    EnglandBritish221394890001
    LEWIS, Thomas Arwyn
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    Director
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    British65122490001
    O'DOHERTY, Jean Crichton
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    Director
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    EnglandBritish13964410001
    PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    Director
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    EnglandBritish5324930001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Director
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    REED, Peter John
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Director
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British21740620001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    UDELHOFEN, Mark James
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    Director
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    American84364350001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Director
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001

    ¿Tiene ENVOPAK GROUP alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 13 nov 2000
    Entregado el 16 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 16 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 22 jul 1998
    Entregado el 25 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 25 jul 1998Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 30 jun 1995
    Entregado el 06 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 mar 1993
    Entregado el 06 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 06 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 31 mar 1987
    Entregado el 03 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 1987Registro de una carga
    • 08 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 16 mar 1987
    Entregado el 20 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 20 mar 1987Registro de una carga
    • 08 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 29 sept 1986
    Entregado el 20 oct 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1986Registro de una carga
    • 14 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 jul 1970
    Entregado el 29 jul 1970
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD.
    Breve descripción
    Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details).
    Personas con derecho
    • The Charente Steamship Co LTD
    Transacciones
    • 29 jul 1970Registro de una carga
    Charge
    Creado el 14 jun 1968
    Entregado el 28 jun 1968
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 jun 1968Registro de una carga
    • 08 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 06 ene 1965
    Entregado el 07 ene 1965
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc
    Breve descripción
    Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1965Registro de una carga
    • 08 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0