ENVOPAK GROUP
Visión general
| Nombre de la empresa | ENVOPAK GROUP |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 00596706 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ENVOPAK GROUP?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ENVOPAK GROUP?
| Dirección de la sede social | 99 Gresham Street London EC2V 7NG |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENVOPAK GROUP?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ENVOPAK LIMITED | 08 ene 1958 | 08 ene 1958 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ENVOPAK GROUP?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENVOPAK GROUP?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 nov 2011 au 31 dic 2011 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2009 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 nov 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ola Tricia Aramita Barreto-Morley el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Philip Matthew Deakin el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Edward Ufland el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Giles Hudson el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario S & J Registrars Limited el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gavin Udall como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Philip Matthew Deakin como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2008 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2007 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 nov 2006 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ENVOPAK GROUP?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Secretario corporativo | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Director | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Director | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Director | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 161583790001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Director | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| HOULDSWORTH, Raymond | Secretario | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | 28059370001 | ||||||||||
| PIPER, Maurice George | Secretario | 8 Chestnut Lane Matfield TN12 7JL Tonbridge Kent | British | 8141120001 | ||||||||||
| PROBERT, Clive Michael Douglas | Secretario | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | 10804410001 | ||||||||||
| WICKETT, Edna May | Secretario | 55 Ladbrooke Crescent Albany Park DA14 4RU Sidcup Kent | British | 36891520001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian Ralph | Secretario | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | 19140250001 | ||||||||||
| ARTHUR, Frank Henry | Director | Well Hill Cottage Well Hill BR6 7RL Chelsfield Kent | England | British | 8141130001 | |||||||||
| BANGLE, Alfred Richard George | Director | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | 20981040001 | ||||||||||
| BANGLE, Alfred Richard George | Director | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | 20981040001 | ||||||||||
| BLACK, Stephen | Director | Les Vielles Terres Havelet GY1 1AZ St Peter Port Guernsey | British | 73554610001 | ||||||||||
| CAMERON, Ian Donald | Director | The Old Rectory Peasemore RG16 0JH Newbury Berkshire | British | 13521010001 | ||||||||||
| HENSHAW, Robert Charles Mayon | Director | 89 Sherbrooke Road SW6 7QL London | British | 66661330001 | ||||||||||
| HOLLINGSWORTH, Roger Colin | Director | 97 Copse Avenue BR4 9NW West Wickham Kent | British | 20963700001 | ||||||||||
| HOULDSWORTH, Raymond | Director | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | 28059370001 | ||||||||||
| KIRBY, Robert Bernard | Director | 1 Manor House Drive Crawford WN8 9QZ Upholland Lancashire | England | British | 221394890001 | |||||||||
| LEWIS, Thomas Arwyn | Director | 35 Clos Glanlliw Pontlliw SA4 9DW Swansea West Glamorgan | British | 65122490001 | ||||||||||
| O'DOHERTY, Jean Crichton | Director | 2g The Glebe Blackheath SE3 9TT London | England | British | 13964410001 | |||||||||
| PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir | Director | Kings Walden Bury SG4 8JU Hitchin Herts | England | British | 5324930001 | |||||||||
| PROBERT, Clive Michael Douglas | Director | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | 10804410001 | ||||||||||
| REED, Peter John | Director | 116 Woodland Way BR4 9LU West Wickham Kent | British | 21740620001 | ||||||||||
| UDALL, Gavin | Director | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| UDELHOFEN, Mark James | Director | 771 Revere Road Glen Ellyn Illinois 60137 Usa | American | 84364350001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian Ralph | Director | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | 19140250001 |
¿Tiene ENVOPAK GROUP alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 13 nov 2000 Entregado el 16 nov 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 22 jul 1998 Entregado el 25 jul 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 30 jun 1995 Entregado el 06 jul 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 02 mar 1993 Entregado el 06 mar 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 31 mar 1987 Entregado el 03 abr 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 16 mar 1987 Entregado el 20 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 29 sept 1986 Entregado el 20 oct 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 jul 1970 Entregado el 29 jul 1970 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD. | |
Breve descripción Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 14 jun 1968 Entregado el 28 jun 1968 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Single debenture | Creado el 06 ene 1965 Entregado el 07 ene 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due etc | |
Breve descripción Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0