STANLEY FRANCE LIMITED

STANLEY FRANCE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTANLEY FRANCE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00599354
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STANLEY FRANCE LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra STANLEY FRANCE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o KPMG LLP
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STANLEY FRANCE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para STANLEY FRANCE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STANLEY FRANCE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    4 páginasRM02

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 17 jun 2014

    3 páginas3.6

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 27 nov 2013

    2 páginas3.6

    Cese del nombramiento de Richard Sproule como director

    1 páginasTM01

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 27 nov 2012

    2 páginas3.6

    Informe del receptor administrativo

    55 páginas3.10

    legacy

    LQ01

    Domicilio social registrado cambiado de * Watermill Farm Hazel End Stansted Essex CM24 8TP* el 08 dic 2011

    2 páginasAD01

    legacy

    3 páginasLQ01

    Déclaration annuelle établie au 22 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ene 2011

    Estado de capital el 18 ene 2011

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 28 feb 2010

    8 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2010 au 28 feb 2010

    3 páginasAA01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2009

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 22 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    Cambio de datos del director Richard Henry Sproule el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Eric Henry Sproule el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Elizabeth Olive Sproule el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Eric Henry Sproule el 01 oct 2009

    3 páginasCH03

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2008

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de STANLEY FRANCE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SPROULE, Eric Henry
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    Secretario
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    British29910001
    SPROULE, Elizabeth Olive
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    Director
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    Northern IrelandBritishCompany Director145790940001
    SPROULE, Eric Henry
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    Director
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    Northern IrelandBritishCompany Director29910001
    BANNON, Adrian Gerard Konrad
    5 Piney Park
    BT9 5QU Belfast
    Antrim
    Secretario
    5 Piney Park
    BT9 5QU Belfast
    Antrim
    British46492910001
    HATFIELD, Timothy Charles David
    1 The Old School Cottages
    Chapel Lane Allostock
    WA16 9LS Knutsford
    Cheshire
    Secretario
    1 The Old School Cottages
    Chapel Lane Allostock
    WA16 9LS Knutsford
    Cheshire
    British4354770001
    MARCH, Michael George
    50 Brushwood Avenue
    Oakmere Park
    CH6 5PY Flint
    Clwyd
    North Wales
    Secretario
    50 Brushwood Avenue
    Oakmere Park
    CH6 5PY Flint
    Clwyd
    North Wales
    British36519320001
    ADAMS, John Gilbert
    Princel House
    Princel Lane Dedham
    CO7 6HD Colchester
    Essex
    Director
    Princel House
    Princel Lane Dedham
    CO7 6HD Colchester
    Essex
    BritishCompany Director74730090001
    ADAMS, Michael William
    108 Dora Road
    SW19 7HJ London
    Director
    108 Dora Road
    SW19 7HJ London
    BritishDirector77455300001
    COVEY, William Gilbert
    33 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Director
    33 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    BritishManaging Director14998230001
    DAVIES, Philip John Leon
    1 Hill Top
    Hale
    WA15 0NH Altrincham
    Cheshire
    Director
    1 Hill Top
    Hale
    WA15 0NH Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishProperty Investor16928630001
    DUCKWORTH, Roger Ian
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishChartered Surveyor674980002
    EDE, Graham Hewett
    Moorings
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Director
    Moorings
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishDirector75781300001
    GILBEY, Jeffrey
    Fairways
    Park Lane Hale
    WA15 9JS Altrincham
    Cheshire
    Director
    Fairways
    Park Lane Hale
    WA15 9JS Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector1503490001
    HATFIELD, Timothy Charles David
    1 The Old School Cottages
    Chapel Lane Allostock
    WA16 9LS Knutsford
    Cheshire
    Director
    1 The Old School Cottages
    Chapel Lane Allostock
    WA16 9LS Knutsford
    Cheshire
    BritishFinance Director4354770001
    MARCH, Michael George
    50 Brushwood Avenue
    Oakmere Park
    CH6 5PY Flint
    Clwyd
    North Wales
    Director
    50 Brushwood Avenue
    Oakmere Park
    CH6 5PY Flint
    Clwyd
    North Wales
    BritishFinance Director36519320001
    SPROULE, Eric Henry
    148 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Director
    148 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern IrelandBritishCompany Director29910001
    SPROULE, Richard Henry
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    Director
    Hill Street
    BT1 2LB Belfast
    51
    County Antrim
    Northern IrelandBritishChartered Accountant111530590001
    TUGHAN, Frederick David
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Director
    Portavo House 176 Warren Road
    BT21 0PJ Donaghadee
    Co Down
    Northern IrelandBritishSolicitor203412740001

    ¿Tiene STANLEY FRANCE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 12 oct 2001
    Entregado el 23 oct 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Breve descripción
    Including (I) 98,99 and 100 crawford st,london W.1,gt.london - westminster; ln 107867; (ii) 188/189 drury lane,holborn,gt.london - camden; ngl 746411; (iii) golborne iron works,golborne,wigan,gt.manchester; GM80001. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transacciones
    • 23 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 102 dic 2011Nombramiento de un receptor o gerente (LQ01)
    • 103 jul 2014Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 1
    Supplemental deed
    Creado el 20 feb 1998
    Entregado el 12 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group member (as therein defined) to the chargee supplemental to the legal charge dated 16 august 1996 and three supplemental deeds respectively dated 12 september 1996 21 november 1996 and 29 august 1997
    Breve descripción
    The l/h property k/a 188-189 drury lane holborn camden t/n NGL746411 and the f/h property k/a golborn iron works golborn wigan greater manchester t/n GM80001 and all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon the benfit of all rights licences and covenants etc.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(At Trustee for Itself and the Other Lenders)
    Transacciones
    • 12 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed
    Creado el 10 nov 1997
    Entregado el 12 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to a legal charge dated 16TH august 1997
    Breve descripción
    F/H 98,99 & 100 crawford street westminster t/no.LN107867, f/h 68 high street tonbridge kent t/no.K414961, f/h 80 the broadway wimbledon merton t/no.TGL44992, l/h units G.01, G.02, G.03, G.04, 1.01 & 1.02 of plaza 535 kings road chelsea kensington and chelsea t/no.634074. L/h land to the rear of G.03, G.04 plaza 535 kings road chelsea kensington and chelsea t/no.NGL645208, l/h units 5-10 skylines isle of dogs and car parking spaces tower hamlets t/no.EGL206027. By way of floating charge the companys undertaking.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 12 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 15 ene 1997
    Entregado el 24 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a part of the ground floor and basement of 188-189 drury lane london and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a golbourne iron works bank street golbourne warrington greater manchester t/no GM80001 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property situate at ruabon road johnstown ruabon clwyd and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 5-10 skylines lime harbour docklands l/b of tower hamlets t/no EGL206027 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 80 the broadway wimbledon merton t/no TGL44992 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 98-100 crawford street london t/no LN107867 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a plaza 535 kings road l/b of kensington and chelsea t/no NGL634074 and NGL645208 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 188-189 drury lane london t/no 373878 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 9 dean street london borough of city of westminster t/no 46641 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 10 mar 1995
    Entregado el 17 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 68 high street tonbridge kent t/no K414961 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 21 sept 1993
    Entregado el 24 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 feb 1993
    Entregado el 18 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit d wellington crescent new malden for details see form 395.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 abr 1991
    Entregado el 19 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings k/a unid d wellington crescent new maldon surrey. Title number sgl 114177.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1991Registro de una carga
    • 25 ago 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 oct 1990
    Entregado el 12 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h land and property lying to the west side of lea green road rainhill st helens merseyside title no:- ms 274017.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 12 oct 1990Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 10 abr 1990
    Entregado el 11 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings on the south west side christ church dorset.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 1990Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 mar 1988
    Entregado el 23 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land hereditaments and premises situated at llangollen road, rhosllanerchrugog, nr. Ruabon, clwyd.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1988Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 sept 1987
    Entregado el 12 sept 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 2, aspull comman, leigh title no. Gm 430858.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1987Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 feb 1985
    Entregado el 11 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 100,000 due from the company to the charges on any account whatsoever pursuant to a mortgage debenture dated 6.2.85.
    Breve descripción
    Various properties at golborne & baton under t/ns. Gm 80001, gm 80002, la 80649 & gm 262371. (for full details see doc M43).
    Personas con derecho
    • P.J.L. Davies.
    • J. Gilbey.
    • D. Fletcher
    Transacciones
    • 11 feb 1985Registro de una carga
    • 15 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 abr 1982
    Entregado el 05 may 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due & other bank from unit pallets limited to the chargee or any account whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Breve descripción
    Land and buildings known as raikes lane, off manchester road, bolton. Title no:- gm 262371.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1982Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 07 abr 1982
    Entregado el 08 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 23,000.
    Breve descripción
    Land at raikes lane, industrial estate, botton, greater manchester, title no:- gm 262371.
    Personas con derecho
    • Unit Pallets Limitedretirement Pension Scheme.
    Transacciones
    • 08 abr 1982Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 16 nov 1978
    Entregado el 26 feb 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land & premises at golborne iron works goldborne greater manchester title number em 80001 together with all fixtures.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 1979Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 16 nov 1978
    Entregado el 26 feb 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H & premises at 36 bank street golbourne manchester together with all fixtures.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 1979Registro de una carga
    • 23 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene STANLEY FRANCE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1Administrador judicial nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gerard Anthony Friar
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Administrador judicial/gestor
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Administrador judicial/gestor
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0