HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00611451 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED?
- Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural (09100) / Explotación de minas y canteras
¿Dónde se encuentra HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Halliburton, The Building 2nd Floor, 578-586 Chiswick High Road W4 5RP London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 29 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Ms Rachel Lynn Johnson como director el 12 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Michael Horsfall como director el 12 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 246 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Eoghan Dixon como director el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Steven Ross Craib como director el 25 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Scot Clifton como director el 25 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Albert Birnie como director el 25 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Scot Clifton como secretario el 25 oct 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 208 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Halliburton Building 4, Chiswick Park 566 Chiswick High Road London W4 5YE England a C/O Halliburton, the Building 2nd Floor, 578-586 Chiswick High Road London W4 5RP el 01 ago 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Jusmell Johanna Graterol Parodi como director el 13 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Charles Frisk como director el 13 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cessation de Halliburton Holdings (No 3) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 dic 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Halliburton Global Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 dic 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cese del nombramiento de Ross Jamie Lindsay como director el 30 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 35 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Marilyn Lolalade Sarah Odunuga como director el 11 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Barry Thomson como director el 01 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Ms Jusmell Johanna Graterol Parodi el 08 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Ms Marilyn Lolalade Sarah Odunuga el 08 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Ross Jamie Lindsay el 08 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Eoghan Dixon el 08 may 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAIB, Steven Ross | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House Scotland | Scotland | British | 328812130002 | |||||
| FORSTER, Archibald Robert | Director | Elliott Industrial Estate DD11 2NF Arbroath Halliburton United Kingdom | Scotland | British | 115388290001 | |||||
| JOHNSON, Rachel Lynn | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton Scotland | Scotland | American | 342496430001 | |||||
| MARTIN, Michael Patrick | Director | 2nd Floor, 578-586 Chiswick High Road W4 5RP London C/O Halliburton, The Building United Kingdom | Scotland | American | 308938740001 | |||||
| CARRIERE, Margaret Estelle | Secretario | 7 Seaton Close SW15 3TJ London | American | 72205450001 | ||||||
| CLIFTON, Scot | Secretario | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | British | 139856420001 | ||||||
| COONEY, Edward Joseph | Secretario | 1 Brackenhill KT11 2EW Cobham Surrey | British | 2203640001 | ||||||
| CRAWLEY, Peter John | Secretario | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 91521200006 | ||||||
| DEERING, John Edward | Secretario | Blenheim Place AB25 2DL Aberdeen 129 Aberdeenshire | British | 131261430001 | ||||||
| MASTERS, Clifford Albert | Secretario | 144 Peperharow Road GU7 2PW Godalming Surrey | British | 584520001 | ||||||
| ROBERTSON TOCHER, Judith | Secretario | Blacktop House Blacktop Kingswells AB15 8QJ Aberdeen | British | 4619160005 | ||||||
| VINT, Richard Clark | Secretario | 22 Connaught Drive KT13 0XA Weybridge Surrey | American | 44114890002 | ||||||
| ABZALOV, Margulan | Director | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | United Kingdom | Kazakh | 251342450001 | |||||
| AMERIGO, Thomas William | Director | 149 Norwich Road Wroxham NR12 8RZ Norwich Norfolk | British | 42319540001 | ||||||
| ANDERSON, Edward John | Director | Burnhead Cottage Benholm DD10 0HX Inverbervie | British | 91817500001 | ||||||
| BARTLETT, Anson | Director | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | Scotland | British | 267658460002 | |||||
| BETTS, Matthew | Director | Howe Moss Drive Dyce AB21 0GD Aberdeen Halliburton House Scotland | United Kingdom | British | 119391640001 | |||||
| BETTS, Matthew | Director | Daisybank Oyne AB52 6QT Insch Aberdeenshire | United Kingdom | British | 119391640001 | |||||
| BIRNIE, Christopher Albert | Director | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | United Kingdom | British | 238583500001 | |||||
| BOWYER, Michael Lewis | Director | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 43449270009 | ||||||
| BRACKER, Stephen Fredrick | Director | 114 Queens Road AB15 4YH Aberdeen | Australian | 91816810001 | ||||||
| BRANNAN, Gavin Thomas | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House Aberdeenshire | Scotland | British | 148501780001 | |||||
| BRIGHTY, Stephen Andrew | Director | Hillcrest House Heath Lane GU15 1EH Camberley Surrey | British | 42204440001 | ||||||
| BRISTON, Andrew Denis | Director | 64 Forest Lane Kirklevington TS15 9ND Stockton Cleveland | British | 104164660001 | ||||||
| BUCHANAN, Alasdair Ian | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House Scotland | Scotland | British | 162046510001 | |||||
| BURNS, Michael Gerard | Director | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | Scotland | British | 115388750001 | |||||
| BURNS, Michael Gerard | Director | 67 Beaconsfield Place AB15 4AD Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 115388750001 | |||||
| CHALKER, Christopher John | Director | The Mill House Bucklerburn Road Peterculter AB14 0NP Aberdeen | Australian | 100608520001 | ||||||
| CLIFTON, Scot | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House Aberdeenshire | Scotland | British | 139856420001 | |||||
| COGHILL, James | Director | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | United Kingdom | British | 200669010001 | |||||
| COOK, Philip | Director | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | United Kingdom | British | 267474020001 | |||||
| COWARD, Julian Mark | Director | Logie House AB51 5EE Pitcaple Aberdeenshire | British | 100608340001 | ||||||
| CROLEY, Russel Lee | Director | Barrowsgate House Drumoak AB31 5EL Banchory | American | 84313040001 | ||||||
| DIXON, Eoghan | Director | 2nd Floor, 578-586 Chiswick High Road W4 5RP London C/O Halliburton, The Building United Kingdom | United Kingdom | Irish | 309120940001 | |||||
| DOWELL, Iain Alexander | Director | Howe Moss Crescent Kirkhill Industrial Estate, Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House Scotland | Scotland | British | 168966640001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HALLIBURTON MANUFACTURING AND SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halliburton Global Holdings Limited | 11 dic 2023 | 566 Chiswick High Road Chiswick Park W4 5YE London C/O Halliburton Building 4 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Halliburton Holdings (No 3) | 06 abr 2016 | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0