COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00614864 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 11 Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent United Kingdom United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COUNTRYSIDE PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 14 nov 1958 | 14 nov 1958 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Michael Philip Woolliscroft como director el 31 mar 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Daniel William King como director el 06 mar 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Registro de la carga 006148641232, creada el 03 mar 2026 | 67 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641231, creada el 05 feb 2026 | 23 páginas | MR01 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 006148641216 | 1 páginas | MR05 | ||
Cancelación total de la carga 006148641228 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 006148641191 | 1 páginas | MR04 | ||
Registro de la carga 006148641230, creada el 09 ene 2026 | 33 páginas | MR01 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 006148641215 | 1 páginas | MR05 | ||
Registro de la carga 006148641228, creada el 23 dic 2025 | 41 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641227, creada el 23 dic 2025 | 23 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641229, creada el 22 dic 2025 | 24 páginas | MR01 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 dic 2025
| 3 páginas | SH01 | ||
Registro de la carga 006148641224, creada el 19 dic 2025 | 34 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641225, creada el 19 dic 2025 | 23 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641226, creada el 19 dic 2025 | 23 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641223, creada el 19 dic 2025 | 22 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641221, creada el 25 nov 2025 | 35 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641222, creada el 25 nov 2025 | 34 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641220, creada el 25 nov 2025 | 51 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 006148641219, creada el 26 nov 2025 | 65 páginas | MR01 | ||
Cambio de datos del director Mr Timothy Charles Lawlor el 08 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 006148641218, creada el 22 oct 2025 | 30 páginas | MR01 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 006148641202 | 1 páginas | MR05 | ||
¿Quiénes son los directivos de COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRY SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent United Kingdom |
| 284895390001 | ||||||||||
| BATES, Clare Jane | Director | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 178363560001 | |||||||||
| DANIELS, Adam Thomas | Director | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 257202580002 | |||||||||
| KING, Daniel William | Director | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | England | British | 308002520001 | |||||||||
| LAWLOR, Timothy Charles | Director | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 302161610001 | |||||||||
| TEAGLE, Stephen John | Director | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 260031470001 | |||||||||
| WARRINGTON, James Edward | Director | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 332062100001 | |||||||||
| WRIGHT, Thomas David | Director | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House United Kingdom | United Kingdom | British | 290719390001 | |||||||||
| COLGRAVE, Wendy Elizabeth | Secretario | High Easter CM1 4RB Chelmsford Ellis Farm Essex England | British | 54431170001 | ||||||||||
| HOYLES, Robin Patrick | Secretario | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | British | 34860250001 | ||||||||||
| PEARCE, Michael Frank | Secretario | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | British | 33032910001 | ||||||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Secretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||||||
| WHITAKER, Gary | Secretario | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | 196344700001 | |||||||||||
| ANDERSON, Bruce Smith | Director | 2 Bramdean View EH10 6JX Edinburgh | Scotland | British | 73849040001 | |||||||||
| BOLEAT, Mark John, Sir | Director | 26 Westbury Road HA6 3BU Northwood Middlesex | England | British | 9157140001 | |||||||||
| CARR-LOCKE, Andrew Charles Phillip | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 2567850002 | |||||||||
| CHAPMAN, Philip Andrew | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 183918150002 | |||||||||
| CHERRY, Alan Herbert | Director | Harvesters Green Street Fryerning CM4 ONS Ingatestone Essex | England | British | 2026150001 | |||||||||
| CHERRY, Graham Stewart | Director | Fridays Fox Road Mashbury CM1 4TJ Chelmsford Essex | England | British | 7228590002 | |||||||||
| CHERRY, Richard Stephen | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 68733260003 | |||||||||
| COLGRAVE, Wendy Elizabeth | Director | High Easter CM1 4RB Chelmsford Ellis Farm Essex England | England | British | 54431170002 | |||||||||
| CROOK, Christopher Peter | Director | 7 Lynton Road Thorpe Bay SS1 3BE Essex | British | 46724000001 | ||||||||||
| DOIG, David John | Director | Damar Lodge The Chase Black Notley CM7 8QX Braintree Essex | British | 51086780001 | ||||||||||
| GUPTA, Patricia | Director | 8 Lodge Road CM9 6HW Maldon Essex | United Kingdom | British | 44865650002 | |||||||||
| JAMIESON, Joanne | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 248317390001 | |||||||||
| KELLEY, Ian Russell | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 81216850001 | |||||||||
| LYONS, Phillip Victor | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 231980680001 | |||||||||
| MCGOWAN, Daniel Hugh | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 75476600004 | |||||||||
| MCPHERSON, Iain Duncan | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 252865210001 | |||||||||
| PEARCE, Michael Frank | Director | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | England | British | 33032910001 | |||||||||
| PICKSTOCK, Samuel Frank | Director | The Crows Nest Holding Coton End Gnosall ST20 0EF Stafford | England | British | 34577430001 | |||||||||
| QUINN, Peter Herbert | Director | Dog House HP5 1UQ Latimer Buckinghamshire | British | 663570001 | ||||||||||
| REYNER, John Neville | Director | Barkway House 7 Limekiln Close SG8 9XP Royston Hertfordshire | England | British | 23283310002 | |||||||||
| SCOTT, Michael Ian | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 290228130001 | |||||||||
| SIBLEY, Earl | Director | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 346400680001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COUNTRYSIDE PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Countryside Properties (Housebuilding) Limited | 06 abr 2016 | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0