EIBL MANAGEMENT LIMITED

EIBL MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEIBL MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00616245
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EIBL MANAGEMENT LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra EIBL MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Embankment West Tower
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EIBL MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EQUITY BROKING MANAGEMENT LIMITED06 ene 200606 ene 2006
    COX BROKING MANAGEMENT LIMITED01 mar 200501 mar 2005
    HAINAULT SECURITIES LIMITED08 dic 195808 dic 1958

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EIBL MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EIBL MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    AABKMTQQ

    Modification des détails de Swinton Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 ago 2021

    2 páginasPSC05
    XABIJK76

    Cancelación total de la carga 10

    1 páginasMR04
    XA4QYYRT

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    XA4G3PM9

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    7 páginasAA
    A9JNMSEL

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X94GJRJ7

    Cese del nombramiento de Janice Deakin como director el 30 dic 2019

    1 páginasTM01
    X8XM8U7U

    Nombramiento de Mr Ian James Donaldson como director el 31 dic 2019

    2 páginasAP01
    X8XM8UBN

    Cese del nombramiento de Scott Stewart Kennedy como director el 30 dic 2019

    1 páginasTM01
    X8XM8U9V

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    7 páginasAA
    A8EQZNAW

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X853GJ7M

    Cese del nombramiento de Annabel Felicity Wilson como secretario el 31 dic 2018

    1 páginasTM02
    X7Z9TBBT

    Cese del nombramiento de David Robert Harding como director el 31 dic 2018

    1 páginasTM01
    X7Z9TB9T

    Nombramiento de Mr Craig David Ball como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01
    X7Z9SK5X

    Nombramiento de Ms Janice Deakin como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01
    X7Z9SK9D

    Nombramiento de Mr Scott Stewart Kennedy como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01
    X7Z9SK3M

    Nombramiento de Dean Clarke como secretario el 31 dic 2018

    2 páginasAP03
    X7Z9SK7L

    Cese del nombramiento de Gilles Normand como director el 03 oct 2018

    1 páginasTM01
    X7GBXCS8

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    7 páginasAA
    A7FCI0X4

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01
    X750VJO9

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    7 páginasAA
    A6FV4UNK

    Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 10

    2 páginasMR05
    X6CVITE2

    Modification des détails de Swinton Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 jun 2017

    2 páginasPSC05
    X6ADEKX6

    ¿Quiénes son los directivos de EIBL MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CLARKE, Dean
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Secretario
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    255366010001
    BALL, Craig David
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector109298830003
    DONALDSON, Ian James
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector253784440001
    BOON, Belinda
    Ropers House
    Vicarage Road, Roxwell
    CM1 4NB Chelmsford
    Secretario
    Ropers House
    Vicarage Road, Roxwell
    CM1 4NB Chelmsford
    British114835210001
    CUGGY, Victoria Louise
    Ranulf Road
    CM6 3GR Little Dunmow
    63
    Essex
    Secretario
    Ranulf Road
    CM6 3GR Little Dunmow
    63
    Essex
    BritishCompany Secretary105782010002
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Secretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    169856760001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Secretario
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    BritishCompany Secretary85213650001
    HARGREAVES, Sally Anne
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    Greater Manchester
    Secretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    Greater Manchester
    EnglishCompany Secretary1778900007
    HEATH, Anne
    Larkins Farm Stondon Road
    Blackmore
    CM4 0JY Ingatestone
    Essex
    Secretario
    Larkins Farm Stondon Road
    Blackmore
    CM4 0JY Ingatestone
    Essex
    British17461300001
    HEATH, Roger Eric
    Titbeech House Terling Road
    Hatfield Peverell
    CM3 2AA Chelmsford
    Essex
    Secretario
    Titbeech House Terling Road
    Hatfield Peverell
    CM3 2AA Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Secretary5653830001
    NICE, Richard Frederick
    70 Heritage Drive
    ME7 3EH Gillingham
    Kent
    Secretario
    70 Heritage Drive
    ME7 3EH Gillingham
    Kent
    British2850930001
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Secretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    189560610001
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secretario
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    British46372950001
    WILSON, Annabel Felicity
    RG1 8DA Reading
    Norman Place
    United Kingdom
    Secretario
    RG1 8DA Reading
    Norman Place
    United Kingdom
    196025800001
    BARDET, Christophe Marie Fred
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchChief Executive165770320001
    CHARLES, Colin David
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    Director
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant46667150002
    CLARE, Anthony Peter
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    Greater Manchester
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    Greater Manchester
    United KingdomBritishDirector51441260002
    CUGGY, Victoria Louise
    1 Canon Road
    Little Dunmow
    CM6 3GF Dunmow
    Essex
    Director
    1 Canon Road
    Little Dunmow
    CM6 3GF Dunmow
    Essex
    BritishCompany Secretary105782010001
    DEAKIN, Janice
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    United Kingdom
    Director
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    United Kingdom
    EnglandBritishDeputy Ceo238355920001
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandFrenchDirector167333040002
    DODDS, Paul Gavin
    Badgers Barn
    Sparrow Lane
    CM22 7BA Hatfield Broad Oak
    Hertfordshire
    Director
    Badgers Barn
    Sparrow Lane
    CM22 7BA Hatfield Broad Oak
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director160890670001
    FISHER, Andrew Charles
    Barngates Lodge, Church Lane
    Binfield
    RG42 5NS Bracknell
    Berkshire
    Director
    Barngates Lodge, Church Lane
    Binfield
    RG42 5NS Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director107491560001
    FRIEND, Gary
    16 Jovian Way
    CO4 9WT Colchester
    Essex
    Director
    16 Jovian Way
    CO4 9WT Colchester
    Essex
    BritishCompliance Officer98993810001
    GIBSON, Andrew James
    21 Acorn Lane
    Cuffley
    EN6 4JQ Potters Bar
    Hertfordshire
    Director
    21 Acorn Lane
    Cuffley
    EN6 4JQ Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant51599670001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Director
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    BritishCompany Secretary85213650001
    HAPLIN, Peter Joseph
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    Greater Manchester
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    Greater Manchester
    United KingdomBritishDirector135757830001
    HARDING, David Robert
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector196407900002
    HEATH, Duncan Rodney
    Larkins Farm Stondon Road
    CM4 0JY Blackmoor
    Essex
    Director
    Larkins Farm Stondon Road
    CM4 0JY Blackmoor
    Essex
    BritishLloyds Underwriter13823360001
    HEATH, Roger Eric
    Titbeech House Terling Road
    Hatfield Peverell
    CM3 2AA Chelmsford
    Essex
    Director
    Titbeech House Terling Road
    Hatfield Peverell
    CM3 2AA Chelmsford
    Essex
    BritishLloyds Underwriter5653830001
    KENNEDY, Scott Stewart
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector211745270001
    KING, Fiona
    South View Cottage Coopers Corner
    Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    Director
    South View Cottage Coopers Corner
    Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    BritishHuman Resources Manager56818220001
    MORLEY, James
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    Director
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    United KingdomUnited KingdomChartered Accountant13374700001
    NORMAND, Gilles
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United KingdomFrenchDirector175288680002
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector130813500001
    POTTS, Nicholas
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    Director
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    EnglandBritishSales & Marketing Director64059360004

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EIBL MANAGEMENT LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    101 Cathedral Approach
    M3 4FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    06 abr 2016
    101 Cathedral Approach
    M3 4FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro756681
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene EIBL MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 26 may 2006
    Creado el 08 ene 2009
    Entregado el 14 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 2017Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 18 may 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession
    Creado el 08 ene 2009
    Entregado el 14 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 21 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Manager investor debenture
    Creado el 05 ene 2006
    Entregado el 21 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to any bondholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge its rights under an agreement or other security asset all f/h or l/h property,all rights under licence or other agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 21 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Syndication investor debenture
    Creado el 05 ene 2006
    Entregado el 21 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor to any bondholder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge its rights under an agreement or any other security asset,all f/h or l/h property,all rights under any licence or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 21 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 22 ago 2005
    Entregado el 01 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All assets assigned or charged under the debenture.
    Personas con derecho
    • Calyon as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transacciones
    • 01 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 jul 2005
    Entregado el 21 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land investments plant and machinery credit balances book debts insurances relevant contracts intellectual property goodwill floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Calyon as Agent and Trustee for the Secured Creditors
    Transacciones
    • 21 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 oct 2004
    Entregado el 27 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge the real property the accounts the insurance policies the proceeds thereof and all related rights the intellectual property any goodwill by way of floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee)
    Transacciones
    • 27 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 may 2002
    Entregado el 31 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 31 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders").
    Creado el 25 abr 2002
    Entregado el 07 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank Plcas Agent and Trustee for the Secured Parties Under the Subordination and Security Trust Deed
    Transacciones
    • 07 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 oct 1973
    Entregado el 31 oct 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    284 and 284A warley hill brentwood essex.
    Personas con derecho
    • Lomband North Central Limited
    Transacciones
    • 31 oct 1973Registro de una carga
    • 24 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0