TEA BLENDING LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | TEA BLENDING LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00625919 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TEA BLENDING LIMITED?
- (1533) /
- (9305) /
¿Dónde se encuentra TEA BLENDING LIMITED?
Dirección de la sede social | Wincanton Plc Methuen Park SN14 0WT Chippenham Wiltshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TEA BLENDING LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BUCHANAN BUTLERS WAREHOUSING SERVICES LIMITED | 02 mar 2004 | 02 mar 2004 |
RED CARNATION GUMS LIMITED | 23 nov 1982 | 23 nov 1982 |
COMMERCIAL & HOUSING INVESTMENTS LIMITED | 15 abr 1959 | 15 abr 1959 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TEA BLENDING LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TEA BLENDING LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graeme Mcfaull como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 jul 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Kempster como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gerard Connell como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Philip Williams como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Phillips como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Graeme Mcfaull el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Gerard Dominic Connell el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Charles Francis Phillips el 01 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2008 | 5 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2007 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2006 | 4 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 288a |
¿Quiénes son los directivos de TEA BLENDING LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Stephen Philip | Secretario | Wincanton Plc Methuen Park SN14 0WT Chippenham Wiltshire | 150983990001 | |||||||
KEMPSTER, Jonathan | Director | Wincanton Plc Methuen Park SN14 0WT Chippenham Wiltshire | England | British | Director | 153034830001 | ||||
CAMERON, Ewen William | Secretario | 'Brunnings' Mount Pleasant Framlingham IP13 9HL Woodbridge Suffolk | British | 50514230001 | ||||||
CAMERON, Ewen William | Secretario | 'Brunnings' Mount Pleasant Framlingham IP13 9HL Woodbridge Suffolk | British | 50514230001 | ||||||
GOATES, Catherine Mary | Secretario | 101 Kingsland Road HP1 1QB Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 73687490001 | ||||||
GOATES, Catherine Mary | Secretario | 116 Woodbridge Road IP4 2NL Ipswich Suffolk | British | 68049130001 | ||||||
PHILLIPS, Charles Francis | Secretario | Wincanton Plc Methuen Park SN14 0WT Chippenham Wiltshire | British | 7270170001 | ||||||
SMITH, Colin Greenough | Secretario | 2 The Cove Hale WA15 8RZ Altrincham Cheshire | British | 38361850002 | ||||||
THOMSON, Paul Thomas | Secretario | 3 Carshalton End CO3 5FB Colchester Essex | British | 49330330001 | ||||||
BAISTER, David John | Director | 10 Lower Road Higher Denham UB9 5EA Uxbridge Middlesex | British | Accountant | 72115710001 | |||||
BATCHELOR, Jeremy David Alton | Director | Rozel House 16 Oast Road RH8 9DU Oxted Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 201934260001 | ||||
BATEMAN, Paul | Director | Sunset View 5 Brudenell Avenue BH13 7NW Poole Dorset | England | British | Company Director | 85091050001 | ||||
CAIRNS, John Kevin | Director | 6 Robert Wallace Close CM23 2TG Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 5119570001 | ||||
CONNELL, Gerard Dominic | Director | c/o Company Secretary Methuen Park SN14 0WT Chippenham Wincanton Plc Wiltshire England | United Kingdom | British | Company Director | 66248140001 | ||||
MAGOR, Richard Boycott | Director | The Lodge TN5 6AR Wadhurst Sussex | British | East India Merchant | 7118790001 | |||||
MARSHALL, Trevor Heslington | Director | 90a Maldon Road CM8 1HR Witham Essex | England | British | Accountant | 21732660003 | ||||
MCFAULL, Graeme | Director | c/o Company Secretary Methuen Park SN14 0WT Chippenham Wincanton Plc Wiltshire England | England | British | Managing Director | 140894060001 | ||||
PHILLIPS, Bruce Andrew | Director | 4 Cedar Terrace Road TN13 3UD Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Company Director | 66616610001 | ||||
PHILLIPS, Charles Francis | Director | 61 Kelmscott Road SW11 6QX London | British | Solicitor | 7270170001 | |||||
REVOIR, Peter Joseph | Director | 16 Woodberry Way E4 7DX London | British | Transport Executive | 41499410002 | |||||
TAYLOR, Martin Noel | Director | Rookwood Bucklesham Road, Foxhall IP10 0AA Ipswich Suffolk | British | Accountant | 46147830003 | |||||
TURNER, John Gordon | Director | 84 Parkanaur Avenue Thorpe Bay SS1 3JB Southend On Sea Essex | British | Transport Executive | 14025180001 | |||||
ZEIDA, Ernest Albert | Director | Glebeside Ainstey Drive, Sparkford BA22 7JT Yeovil Somerset | German | Company Director | 89604340001 |
¿Tiene TEA BLENDING LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 22 ago 1977 Entregado el 26 ago 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or town & city properties limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción 7 & 9 swan st in the city of manchester title no la 11681. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 22 ago 1977 Entregado el 26 ago 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or town & city properties limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Land shop and premises 65 school road, sale, greater manchester and extending on the first floor over part of the adjoining property 65A school road. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 17 jun 1975 Entregado el 23 jun 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or town & city properties LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción 100, 100A & part of 100B high street, feltham hounslow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 19 dic 1969 Entregado el 31 dic 1969 | Pendiente | Cantidad garantizada £2,593,588 due from town and city properties limited to the chargee pursuant to a deed of covenant dated 26/11/69 | |
Breve descripción 7-9 swan street, manchester. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 11 dic 1969 Entregado el 23 dic 1969 | Pendiente | Cantidad garantizada £2,593,588 due from town and city properties limited to the chargee 26/11/69 to a deed of covenant dated | |
Breve descripción 65 school road, sale, cheshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0