INSATSU CHOSA LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INSATSU CHOSA LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00626545 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INSATSU CHOSA LIMITED?
- Alquiler y arrendamiento de otras máquinas, equipo y bienes tangibles n.c.p. (77390) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra INSATSU CHOSA LIMITED?
| Dirección de la sede social | Nimbus House Liphook Way, Twenty Twenty Industrial Estate ME16 0FZ Maidstone England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INSATSU CHOSA LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DANWOOD (EASTERN) LTD | 23 nov 1989 | 23 nov 1989 |
| DANWOOD OFFICE EQUIPMENT (EASTERN) LIMITED | 30 oct 1987 | 30 oct 1987 |
| DANWOOD LEAMON LTD | 23 abr 1959 | 23 abr 1959 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INSATSU CHOSA LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INSATSU CHOSA LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Harrisson Place Whisby Road Lincoln LN6 3DG | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Harrisson Place Whisby Road Lincoln LN6 3DG | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Harrisson Place Whisby Road Lincoln LN6 3DG a Nimbus House Liphook Way, Twenty Twenty Industrial Estate Maidstone ME16 0FZ el 15 mar 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 sept 2017 au 28 feb 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ross David Eaglestone como director el 02 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gerard Noel Small como director el 02 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ross David Eaglestone como secretario el 02 mar 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jason Patrick Collins como director el 02 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Martin Keith Randall como director el 02 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Graham Thomas como director el 02 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Ronald William Francis como director el 01 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ross David Eaglestone como director el 01 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gerard Noel Small como director el 01 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ross David Eaglestone como secretario el 12 jun 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Janes como secretario el 12 jun 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Prance Janes como director el 12 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stephen Ronald William Francis el 16 feb 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INSATSU CHOSA LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Jason Patrick | Director | Liphook Way, Twenty Twenty Industrial Estate ME16 0FZ Maidstone Nimbus House England | United Kingdom | British | 129544760001 | |||||
| RANDALL, Martin Keith | Director | Liphook Way, Twenty Twenty Industrial Estate ME16 0FZ Maidstone Nimbus House England | United Kingdom | British | 40012240002 | |||||
| THOMAS, Graham | Director | Liphook Way, Twenty Twenty Industrial Estate ME16 0FZ Maidstone Nimbus House England | United Kingdom | British | 184000300001 | |||||
| CROSS, Scythia | Secretario | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | 174785480001 | |||||||
| EAGLESTONE, Ross David | Secretario | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | 198857940001 | |||||||
| JANES, Steven | Secretario | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | 182135970001 | |||||||
| SARGEANT, Simon Andrew | Secretario | Clooney Roughton LN10 6YJ Woodhall Spa Lincolnshire | British | 19897140001 | ||||||
| WILSON, Darren Peter | Secretario | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | British | 36877020003 | ||||||
| DANIELS, Colin Geoffrey Vaughan | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | United Kingdom | British | 2236010001 | |||||
| EAGLESTONE, Ross David | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | England | British | 199472860001 | |||||
| FOTHERINGHAM, Martin Muir | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | England | British | 89393730004 | |||||
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | England | British | 105961550002 | |||||
| HERON, Kenneth | Director | 73 Nettleham Road LN2 1RT Lincoln Lincolnshire | England | British | 2236020001 | |||||
| HUGHES, Victor Arthur Richard | Director | 71 South Park LN5 8ES Lincoln Lincolnshire | British | 2236030001 | ||||||
| JANES, Steven Prance | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | England | British | 157715390001 | |||||
| REEVE, Graham Andrew | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | England | British | 24207350002 | |||||
| SMALL, Gerard Noel | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | United Kingdom | Irish | 81492100001 | |||||
| SMALL, Gerard Noel | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | United Kingdom | Irish | 81492100001 | |||||
| WARD, Nigel James | Director | Harrisson Place Whisby Road LN6 3DG Lincoln | England | British | 166510540001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INSATSU CHOSA LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Danwood Group Ltd | 06 abr 2016 | Liphook Way, Twenty Twenty Industrial Estate ME16 0FZ Maidstone Nimbus House Kent England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene INSATSU CHOSA LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 28 jun 2006 Entregado el 04 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 06 may 1987 Entregado el 13 may 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 16 nov 1983 Entregado el 23 nov 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on book & other debts floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. (Exclusive mentioned above). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 13 jul 1981 Entregado el 17 jul 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over companys freehold or leasehold properties fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 19 jun 1978 Entregado el 30 jun 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a 96,cotton grove road norwich. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0