CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00629193
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KENNEDY'S SCAFFOLDING LIMITED09 abr 199109 abr 1991
    WESTERN SCAFFOLDING COMPANY LIMITED29 may 195929 may 1959

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Drayton Hall Church Road West Drayton Middlesex England UB7 7PS a 15 Canada Square London E14 5GL el 13 ene 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 20 dic 2016

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Richard Friend Allan como secretario el 07 jun 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Richard Friend Allan como director el 07 jun 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 may 2016

    Estado de capital el 12 may 2016

    • Capital: GBP 4,984.8
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 mar 2015

    Estado de capital el 25 mar 2015

    • Capital: GBP 4,984.8
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 mar 2014

    Estado de capital el 20 mar 2014

    • Capital: GBP 4,984.8
    SH01

    Nombramiento de Mr Mark Hooper como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Friend Allan como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Skipp como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Judd como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Richard Friend Allan como secretario

    2 páginasAP03

    Cambio de datos del director Mrs Victoria Anne George el 08 may 2013

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Richard John Skipp como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rachel Amey como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom* el 14 mar 2013

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GEORGE, Victoria Anne
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Tax Adviser134024500001
    HOOPER, Mark
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Director
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director183414240001
    ALLAN, Richard Friend
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    181728890001
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830001
    GORMAN, Jeremy Philip
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    160675550001
    JUDD, Christopher Francis
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    Secretario
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    169521430001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British829660002
    REYNOLDS, Michael Thomas
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    British4978610002
    RHODES, Jeremy
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    Secretario
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    British129206660001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Secretario
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    TURNER, Lucy Finch
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    British133976740001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Secretario
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    BritishSolicitor99402260002
    AINLEY, Paul Raymond
    Manasseh
    Darrington Road
    WF8 3RY Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    Manasseh
    Darrington Road
    WF8 3RY Pontefract
    West Yorkshire
    BritishCompany Director36049300001
    ALLAN, Richard Friend
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary183409640001
    AMEY, Rachel Nancye
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Director
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant133976650005
    BINGHAM, Richard Keith
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    Director
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    BritishAccountant131046090001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Director
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    BritishChartered Accountant40873830002
    CRAIG, William Thomas
    Dunelm Moat Lane
    Prestwood
    HP16 9BT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Director
    Dunelm Moat Lane
    Prestwood
    HP16 9BT Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director33602340001
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830001
    GAMMAGE, Julian
    99 High Road
    Warmsworth
    DN4 9LZ Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    99 High Road
    Warmsworth
    DN4 9LZ Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director13299700001
    GILLESPIE, Andrew James
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant89560440001
    JACKSON, Francis Keith John
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    Director
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director15469790001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant829660002
    REYNOLDS, Michael Thomas
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant4978610002
    SKIPP, Richard John
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Director
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director164010970001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Director
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Director
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    EnglandBritishSolicitor99402260002
    WIDDOWSON, Ian Richard
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant16941000001
    CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    131421100001

    ¿Tiene CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating security document
    Creado el 20 jul 2001
    Entregado el 26 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined)
    Breve descripción
    Freehold properties,(i) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Creditors
    Transacciones
    • 26 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creado el 28 abr 1987
    Entregado el 07 may 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Securing sterling 3,458,848 10% debenture stock 1986/91 of cape industries public limited company and all other moneys due or to become due pursuant to this deed.
    Breve descripción
    And all patents. See doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transacciones
    • 07 may 1987Registro de una carga
    • 09 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 29 ene 1985
    Entregado el 14 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1) the f/h l/h property of the company 2) all stocks shares bonds and securities 3) all book & other debts 4) uncalled capital goodwill and all patents. Paten applications trade marks etc. 5) undertaking and all other property assets and rights (for full details see doc M46).
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transacciones
    • 14 feb 1985Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 29 ene 1985
    Entregado el 04 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to national westminister bank PLC as trustee for itself and other banks named therein on any account whatsoever.
    Breve descripción
    A specific eqitable charge over the companys f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets presnt and future including and the goodwill bookdebts benefit of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminister Bank Plcand Other Banks (See Doc for Details).
    Transacciones
    • 04 feb 1985Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 11 nov 1982
    Entregado el 18 nov 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital, with all buildings trade & other fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 nov 1982Registro de una carga

    ¿Tiene CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    13 dic 2017Fecha de disolución
    20 dic 2016Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0