CAPARO INDUSTRIES PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCAPARO INDUSTRIES PLC
    Estado de la empresaEn administración
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 00630473
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CAPARO INDUSTRIES PLC?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Dirección de la sede social
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    L.K.INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED16 jun 195916 jun 1959

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2015
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2016
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta14 jun 2017
    Próxima declaración de confirmación vence28 jun 2017
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    26 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    28 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    26 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    24 páginasAM10

    Aviso de nombramiento de un administrador suplente o adicional

    3 páginasAM11

    Aviso de orden de destitución del administrador de la oficina

    14 páginasAM16

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    26 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    26 páginasAM10

    Aviso de orden de destitución del administrador de la oficina

    14 páginasAM16

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    8 páginasRM02

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Aviso de orden de destitución del administrador de la oficina

    18 páginasAM16

    Aviso de nombramiento de un administrador suplente o adicional

    3 páginasAM11

    Informe de progreso del administrador

    30 páginasAM10

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:C.O. To file progress reports annually not 6 monthly.
    3 páginasLIQ MISC OC

    Informe de progreso del administrador

    31 páginasAM10

    Domicilio social registrado cambiado de 7 More London Riverside London SE1 2RT a Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL el 09 oct 2017

    2 páginasAD01

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Aviso de extensión del período de la administración

    2 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    28 páginasAM10

    ¿Quiénes son los directivos de CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAILEY, Stephen Geoffrey
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    Secretario
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    British108203800001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Secretario
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    HYLAND, Matthew Edward William
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Secretario
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    194838470001
    JEAVONS, William Geoffrey
    1 The Grange
    Wombourne
    WV5 9HX Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    1 The Grange
    Wombourne
    WV5 9HX Wolverhampton
    West Midlands
    British11293410001
    MASON, Georgina
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Secretario
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    173195350001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secretario
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British10618480001
    STILWELL, Michael James
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Secretario
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    150882120001
    BUTLER, Richard Gareth John
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    Director
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    EnglandBritish117859680001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Director
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    DAWSON, Douglas, Dr
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Director
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    EnglandBritish117734230001
    EMMENEGGER, Charles E
    1819 Clarkson Road
    FOREIGN Chesterfield
    Missouri 63017
    Usa
    Director
    1819 Clarkson Road
    FOREIGN Chesterfield
    Missouri 63017
    Usa
    United States Of America37965200001
    GANE, Christopher Nigel
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Director
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    ScotlandBritish73268030001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Director
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    Director
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    British12310490001
    HAUXWELL, Timothy Norbury
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    Director
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    British70993740001
    JARVIS, Andrew Laurence
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    Director
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    United KingdomBritish93158620001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Director
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LORMOR, Paul Frederick
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    Director
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    British30814040001
    MEYER, John Joseph
    14929 Greenbury Hill Court
    Chesterfield
    Missouri 63017
    Missouri
    Director
    14929 Greenbury Hill Court
    Chesterfield
    Missouri 63017
    Missouri
    UsaAmerican147066260001
    MORRILL, Dennis
    Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    17
    Worcestershire
    Director
    Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    17
    Worcestershire
    United KingdomBritish111395730002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Director
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish108440160002
    PAHILAJANI, Sunil
    A-1, 54, Ground Floor
    Safdarjang Enclave
    New Dehli
    110016
    India
    Director
    A-1, 54, Ground Floor
    Safdarjang Enclave
    New Dehli
    110016
    India
    Indian119093750001
    PAUL, Akash, The Honourable
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    Director
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish49303360005
    PAUL, Akhil
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Director
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish147065830001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Director
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Director
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    PAUL, Anjli, The Hon
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Director
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    United KingdomBritish110279150001
    PAUL OF MARYLEBONE, The Lord
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Director
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    EnglandBritish11293420003
    PAY, Jason Christopher
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Director
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    EnglandBritish126516810001
    SCHEELE, Nicholas, Sir
    Caparo House
    Popes Lane
    B69 4PJ Oldbury
    West Midlands
    Director
    Caparo House
    Popes Lane
    B69 4PJ Oldbury
    West Midlands
    British American116839800001
    SHAW, Christopher Norman
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    Director
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    United KingdomBritish28831060001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10618480001

    ¿Tiene CAPARO INDUSTRIES PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 15 jul 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    F/H real estate:. Cmt engineering, congreaves road, cradley heath t/no WM904133.. Units 9 & 13 -5-7 wenlock road, london t/no's EGL525392, EGL525389 and EGL525391.. Land adjoing walsall canal, old birchills, walsall t/no WM928137. (For further details of properties charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Transacciones
    • 15 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 06 jul 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    F/H land adjoining walsall canal old birchills walsall t/no WM928137. F/h land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood t/no WM664003. F/h land and buildings o the north east side of miner street walsall t/no WM383832. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Caparo Pensions Scheme Trustee Limited
    Transacciones
    • 06 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    • 222 oct 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 222 oct 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 213 nov 2019Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 2
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 05 jul 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    F/H land k/a cmt engineering corngreaves road cradley heath t/no WM904133. F/h land (ground lease) k/a units 9 - 5-7 wenlock road london t/nos EGL525392, EGL525389, EGL525394 and EGL525391. Trade mark registered in the UK with number 2623030 in relation to the word mark "barton filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. trade mark registered in the republic of ireland with number N247732 in relation to the word mark "barton" filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 05 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 01 jul 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    F/H property being the land adjoining walsall canal old birchills walsall (WM928137) land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood (WM664003) and land and building on the north east side of miner walsall (WM383832). Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Caparo Group Limited
    Transacciones
    • 01 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    Share charge
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 13 ago 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right title and interest in the shares being 10,000 ordinary shares and all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited in Its Capacity as Trustee for the Caparo 1988 Pension Scheme
    Transacciones
    • 13 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    Legal mortgage
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 09 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property land adjoining walsall canal, old bircills walsall, t/no.WM928137; land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood, t/no.WM664003; land and buildings on the north east side of miner street walsall, t/no.WM383832 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 09 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Share charge
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 06 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All shares in caparo india limited and all related rights. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Share charge
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 05 ago 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or geneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Caparo Group Limited
    Transacciones
    • 05 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    Share charge
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 05 ago 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Caparo PLC
    Transacciones
    • 05 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    Share charge
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 05 ago 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Shares mean in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Caparo Group Limited
    Transacciones
    • 05 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    Security agreement
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 06 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 16 feb 2009
    Entregado el 18 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a as land lying to the west of raybould's bridge road, reedswood, land adjoining walsall canal, old brichills, walsall and land and buildings to the north east side of miner street, walsall t/no WM66003, WM928137, and WM383832.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 20 feb 2009
    • 20 feb 2009
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 05 jul 2007
    Entregado el 07 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H properties k/a units 9 and 13 and parking spaces 21 and 22 "estilo wenlock road london.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 23 feb 2007
    Entregado el 28 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a corngreaves road cradley t/no WM489303.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 05 abr 1985
    Entregado el 12 abr 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All ordinary and deferred shared in caparo management services limited held in the name of fenchurch securities LTD. All ordinary and deferred shares in barton group PLC owned by the charger.
    Personas con derecho
    • Kleinwort, Benson Limited.
    Transacciones
    • 12 abr 1985Registro de una carga

    ¿Tiene CAPARO INDUSTRIES PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 oct 2015Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Profesional
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    2Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Suzanna Vida Marshall
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Administrador judicial/gestor
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Andrew Lamb
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Administrador judicial/gestor
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0