ARJO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARJO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00632658
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARJO LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ARJO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Arjohuntleigh House Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Bedfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARJO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ARJO MECANAIDS LIMITED24 jul 198724 jul 1987
    MECANAIDS LIMITED14 jul 195914 jul 1959

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARJO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ARJO LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARJO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mr Harnish Mathuradas Hadani como director el 08 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christoffer David Erik Franzen como director el 08 jul 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 03 jul 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt como director el 01 mar 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Claes Bronsgaard Pedersen como director el 01 mar 2015

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 jul 2014

    Estado de capital el 01 jul 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Christoffer David Erik Franzen como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Mark Bloom como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nils Malmquist como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Khizer Ibrahim como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Khizer Ismail Ibrahim como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alpesh Khakhar como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    16 páginasAA

    Nombramiento de Mr Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Leif Martensson como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ARJO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    155156690001
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118671260002
    HADANI, Harnish Mathuradas
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    EnglandBritish168756590001
    PEDERSEN, Claes Bronsgaard
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    DenmarkDanish196379050001
    LOCK, Robert Francis
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    Secretario
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    British61939850001
    RICHARDSON, Bruce Nigel
    9 Aggs Close
    Gotherington
    GL52 9HD Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    9 Aggs Close
    Gotherington
    GL52 9HD Cheltenham
    Gloucestershire
    British86365790001
    TELLING, Deborah Joanne
    Roslyn 11 Kent Avenue
    HR9 5AH Ross On Wye
    Herefordshire
    Secretario
    Roslyn 11 Kent Avenue
    HR9 5AH Ross On Wye
    Herefordshire
    British86321030002
    FRANZEN, Christoffer David Erik
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandSwedish188458510001
    GOULD, Andrew Simon
    81 Swallow Park
    Thornbury
    BS35 1LU Bristol
    Director
    81 Swallow Park
    Thornbury
    BS35 1LU Bristol
    British94442560002
    HARWOOD, Mark Steven
    Mulberry House
    27 Springfield
    GL8 8EN Tetbury
    Gloucestershire
    Director
    Mulberry House
    27 Springfield
    GL8 8EN Tetbury
    Gloucestershire
    British61768290002
    IBRAHIM, Khizer Ismail
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish180060740001
    JONES, Ian
    Dallow Road
    LU1 1TD Luton
    310-312
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Dallow Road
    LU1 1TD Luton
    310-312
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish243954370001
    KHAKHAR, Alpesh
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish166582980001
    LINDSTROM, Hans
    Ornasvagen 95
    FOREIGN 302 40 Halmstad
    Sweden
    Director
    Ornasvagen 95
    FOREIGN 302 40 Halmstad
    Sweden
    Swedish31203220001
    LOCK, Robert Francis
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    Director
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    United KingdomBritish61939850001
    MALMQUIST, Nils Johan Mikael
    Banvagen 36
    S 435 43 Molnlyeke
    Sweden
    Director
    Banvagen 36
    S 435 43 Molnlyeke
    Sweden
    SwedenSwedish47311390001
    MARTENSSON, Leif Erik
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    SwedenSwedish153479400001
    NILSSON, Peter
    Rodhakavagen 31
    Skurup 527400
    FOREIGN Sweden
    Director
    Rodhakavagen 31
    Skurup 527400
    FOREIGN Sweden
    Swedish45984890001
    OLDERSHAW, Stephen John
    Fir Tree House
    4 Chestnut Close
    WR3 7SZ Fernhill Heath
    Worcestershire
    Director
    Fir Tree House
    4 Chestnut Close
    WR3 7SZ Fernhill Heath
    Worcestershire
    British74921170002
    PARSONS, Robert
    7 Ranchway
    BS20 8DQ Portishead
    Somerset
    Director
    7 Ranchway
    BS20 8DQ Portishead
    Somerset
    EnglandBritish73395620001
    RICHARDSON, Bruce Nigel
    9 Aggs Close
    Gotherington
    GL52 9HD Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    9 Aggs Close
    Gotherington
    GL52 9HD Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish86365790001
    STORK, Matthew William
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160838320001
    VACHER, Peter Edward
    11 Walker Gardens
    Hedge End
    SO30 2RH Southampton
    Hampshire
    Director
    11 Walker Gardens
    Hedge End
    SO30 2RH Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish117473420001
    VAN DEN BELT, Robert Nicolaas Wilko
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    SwedenDutch175232950001
    WOZENCROFT, Andrew John
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    Director
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    British16102100001

    ¿Tiene ARJO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 05 dic 1990
    Entregado el 20 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the and the obligars under the financing documents company to the chargee and/or the lenders.
    Breve descripción
    (See form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Union Bank of Switzerland.
    Transacciones
    • 20 dic 1990Registro de una carga
    • 13 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 1989
    Entregado el 03 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 1989Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 20 feb 1985
    Entregado el 20 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings on north side of st. Catherine st. Gloucester, gloucs. Title no: gr 44708.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 feb 1985Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 05 nov 1984
    Entregado el 05 nov 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land situated at skinner st catherine st. Gloucester, gloucs. Title nos:- GR28301. Gr 54431 & gr 54433.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 nov 1984Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 24 oct 1984
    Entregado el 29 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings on the west side of skinner street title no gr 54431 f/h 18, 20,22,30,32, st catherine street title no. Gr 54433 f/h land and buildings 24 st catherine street title no gr 28301 including trade fixtures. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry
    Transacciones
    • 29 oct 1984Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0