HMV CARD SERVICES LIMITED

HMV CARD SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHMV CARD SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00635858
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HMV CARD SERVICES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HMV CARD SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Windsor House
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HMV CARD SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HMV SHOPS LIMITED12 may 198612 may 1986
    RADIO RENTALS THAMESDOWN CABLE LIMITED17 jun 198317 jun 1983
    CLEARVISION,LIMITED27 ago 195927 ago 1959

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HMV CARD SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 abr 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HMV CARD SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Ian Peter Kenyon como director el 31 ene 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Trevor Philip Moore como director el 08 feb 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elaine Marriner como director el 24 ene 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elaine Marriner como secretario el 24 ene 2013

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Ian Peter Kenyon como director el 03 sept 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Trevor Philip Moore como director el 03 sept 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Simon Richard Fox como director el 03 sept 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 abr 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 may 2012

    Estado de capital el 11 may 2012

    • Capital: GBP 85,570
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR el 13 mar 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Neil Bright como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 abr 2010

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Elaine Marriner el 10 may 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Simon Richard Fox el 10 may 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Elaine Marriner el 10 may 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Neil Irvine Bright el 10 may 2010

    2 páginasCH01

    Resoluciones

    Resolutions
    13 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 abr 2009

    3 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de HMV CARD SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Secretario
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Secretario
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Secretario
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British40470020001
    RITCHIE, Ian
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    Secretario
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    British68246050001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Secretario
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secretario
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Director
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    British9950440002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Director
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    United KingdomBritish180993450001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Director
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Director
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    KENYON, Ian Peter
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107735600001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Director
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Director
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MOORE, Trevor Philip
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113047410001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001

    ¿Tiene HMV CARD SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 may 1998
    Entregado el 04 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transacciones
    • 04 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Creado el 14 may 1998
    Entregado el 15 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transacciones
    • 15 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 mar 1998
    Entregado el 09 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Emi Group PLC (As Security Trustee for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transacciones
    • 09 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 mar 1998
    Entregado el 09 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Breve descripción
    By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Swiss Bank Corporation as "Security Agent"Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Security Trustee or as an Additional Trustee for the Purpose of, and in Accordance with, the Senior Facility Agreement
    Transacciones
    • 09 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 26 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0