CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED

CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHEMICAL INNOVATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00637686
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    • fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. (20590) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    217 Walton Summit Road
    Bamber Bridge
    PR5 8AQ Preston
    Lancashire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    COMPOUNDING INGREDIENTS LIMITED 23 sept 195923 sept 1959

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 27 ago 2021

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    3 páginasSH20

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2020

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de PO Box PR5 8AQ 271 Walton Summit Walton Summit Rod Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ England a 217 Walton Summit Road Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ el 29 abr 2021

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 27 Riverside Way Uxbridge Middlesex UB8 2YF a PO Box PR5 8AQ 271 Walton Summit Walton Summit Rod Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ el 27 abr 2021

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Citco Management Uk Ltd como secretario el 28 jun 2019

    2 páginasAP04

    Declaración de confirmación presentada el 07 ago 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2019

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Bernd Paul Josef Helfrich como director el 30 abr 2019

    1 páginasTM01

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 13 nov 2019

    2 páginasPSC09

    Declaración de confirmación presentada el 07 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Birgitt Michaela Nord como secretario el 29 mar 2019

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 07 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Charles Richard Spalton como director el 30 abr 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017

    14 páginasAA

    Nombramiento de Heidi Ann Weiler como director el 20 oct 2017

    3 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016

    24 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CITCO MANAGEMENT UK LTD
    Albemarle Street
    W1S 4HQ London
    7
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Albemarle Street
    W1S 4HQ London
    7
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02656801
    252274080001
    HECKMANN, Gert Gunter Werner, Dr
    Walton Summit Road
    Bamber Bridge
    PR5 8AQ Preston
    217
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Walton Summit Road
    Bamber Bridge
    PR5 8AQ Preston
    217
    Lancashire
    United Kingdom
    GermanyGerman197800590001
    WEILER, Heidi Ann, Ms.
    Willow Lake Boulevard
    P.O. Box 64683
    St Paul
    1200
    Minnesota 55164-0683
    United States
    Director
    Willow Lake Boulevard
    P.O. Box 64683
    St Paul
    1200
    Minnesota 55164-0683
    United States
    United StatesAmerican239047270001
    ASTLES, Peter Blair
    165 Shaftsbury Avenue
    Timperley
    WA15 7AY Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    165 Shaftsbury Avenue
    Timperley
    WA15 7AY Altrincham
    Cheshire
    British14727110001
    NORD, Birgitt Michaela
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Secretario
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    221512510001
    SMART, Iain
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    Secretario
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    British30605140001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Secretario
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    British78366970002
    VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Secretario corporativo
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01031815
    110906090002
    ASH, Arthur Burr
    292 Roosevelt Place
    Grosse Pointe Michigan 48230
    FOREIGN
    Usa
    Director
    292 Roosevelt Place
    Grosse Pointe Michigan 48230
    FOREIGN
    Usa
    Usa14727120001
    ASTLES, Peter Blair
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Director
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish14727110003
    ASTLES, Peter Blair
    94 Stockport Road
    Timperley
    WA15 7SN Altrincham
    Cheshire
    Director
    94 Stockport Road
    Timperley
    WA15 7SN Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish14727110003
    BENAROUS, Aissa
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    UkBritish114284480001
    BENAROUS, Aissa
    11a Trafalgar Road
    Birkdale
    PR2 8EA Southport
    Merseyside
    Director
    11a Trafalgar Road
    Birkdale
    PR2 8EA Southport
    Merseyside
    British60210410001
    BURLEY, Nicholas James
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Director
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish122799590001
    CAPPS, Samuel Henderson
    47 Daily Hills Circle
    Ringgold Georgia 30736
    FOREIGN
    Usa
    Director
    47 Daily Hills Circle
    Ringgold Georgia 30736
    FOREIGN
    Usa
    Usa14727140001
    COX, Stephen John
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    EnglandBritish16542850004
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    Director
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    EnglandBritish105961550001
    GOMBERG, Edward Nicholas
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    37406 Tennessee
    Usa
    Director
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    37406 Tennessee
    Usa
    Usa14727150004
    GOMBERG, Helen Elizabeth
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    FOREIGN Tennessee 37406 Usa
    Director
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    FOREIGN Tennessee 37406 Usa
    American41936190002
    GOMBERG, Jeffrey Gregory
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    Tennessee 37406
    Usa
    Director
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    Tennessee 37406
    Usa
    American30605130003
    HARRIS, Howard Elliott
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    Director
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    British93378750001
    HAY, Nigel Bruce
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish124316170001
    HAY, Nigel Bruce
    The New Shippen
    Higher Lane Scorton
    PR3 1BE Preston
    Lancashire
    Director
    The New Shippen
    Higher Lane Scorton
    PR3 1BE Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish124316170001
    HELFRICH, Bernd Paul Josef
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    GermanyGerman197801580001
    MARTIN, Robert Stephen
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish150864050001
    MAUNDRELL, Graham Lloyd
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish56093930002
    MELTHAM, John David
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish74570910001
    MENENDEZ, Joseph Henry
    32 Iverna Gardens
    W8 6TW London
    Director
    32 Iverna Gardens
    W8 6TW London
    UsaAmerican127225800001
    MILLER, Matthew Kerr
    Hollins Lane
    SK6 5DA Marple Bridge
    106
    Cheshire
    Director
    Hollins Lane
    SK6 5DA Marple Bridge
    106
    Cheshire
    United KingdomBritish179720330001
    O'CONNOR, Calvin James John
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    Director
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16253240001
    OLIVER, John Lancaster
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    Director
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom116941050001
    SIMMONDS, Barrie
    60 Fairlands Road
    BL9 6QB Bury
    Greater Manchester
    Director
    60 Fairlands Road
    BL9 6QB Bury
    Greater Manchester
    British60210430001
    SMART, Iain
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    Director
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    British30605140001
    SPALTON, Charles Richard
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Director
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish1786610001
    WEXLER, Eric Monroe
    523 Fern Trail
    Signal Mountain
    Tennessee 37377-3168
    Usa
    Director
    523 Fern Trail
    Signal Mountain
    Tennessee 37377-3168
    Usa
    American30605120003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Kommerling Uk Ltd
    Riverside Way
    Cowley
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    England
    06 abr 2016
    Riverside Way
    Cowley
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    England
    No
    Forma jurídicaLimited
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House London
    Número de registro04028071
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    08 ago 201613 nov 2019La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que existe una persona registrable en relación con la empresa, pero no la ha identificado.

    ¿Tiene CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 oct 2013
    Entregado el 09 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 09 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 27 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 oct 2013
    Entregado el 04 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ge Factofrance S.A.S.
    Transacciones
    • 04 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 27 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 abr 2009
    Entregado el 01 may 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 01 may 2009Registro de un cargo (395)
    • 30 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 07 dic 2007
    Entregado el 21 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 21 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 ago 2005
    Entregado el 12 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transacciones
    • 12 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 20 may 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 mar 2003
    Entregado el 28 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 mar 2003
    Entregado el 28 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage the f/h property known as 217 walton summit road, walton summit centre, bamber bridge, preston, lancashire, PR5 8AQ. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 nov 1982
    Entregado el 09 dic 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H unit 217, walton summit centre, bamber bridge. Preston, lancashire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 dic 1982Registro de una carga
    • 22 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on a building agreement
    Creado el 06 abr 1979
    Entregado el 24 abr 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the interest of the company in a building agreement 10.1.79 between central lancashire new town development corporation & the company relating to unit 217, walton summit centre, bomlier bridge, preston, lancashire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 abr 1979Registro de una carga
    • 22 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 dic 1974
    Entregado el 24 dic 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & bldg. On the northeast side of dearding st, greater manchester.
    Personas con derecho
    • Mercantile Credit Co LTD
    Transacciones
    • 24 dic 1974Registro de una carga
    • 22 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 09 ago 1974
    Entregado el 20 ago 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    581 lytham road, blackpool. Lancs, together with land forming the site & appointment thereto.
    Personas con derecho
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transacciones
    • 20 ago 1974Registro de una carga
    • 22 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0