ENGLISH PROPERTY CORPORATION

ENGLISH PROPERTY CORPORATION

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENGLISH PROPERTY CORPORATION
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 00640408
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENGLISH PROPERTY CORPORATION?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra ENGLISH PROPERTY CORPORATION?

    Dirección de la sede social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENGLISH PROPERTY CORPORATION?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ENGLISH PROPERTY CORPORATION LIMITED26 oct 195926 oct 1959

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENGLISH PROPERTY CORPORATION?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENGLISH PROPERTY CORPORATION?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5TS el 09 may 2017

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ a No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP el 20 oct 2016

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 sept 2016

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Emily Ann Mousley como director el 30 jun 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman como director el 23 jun 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 19 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ene 2016

    Estado de capital el 13 ene 2016

    • Capital: GBP 2,090.275536
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ene 2015

    Estado de capital el 18 ene 2015

    • Capital: GBP 2,090.275536
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr David Leonard Grose el 29 ene 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 19 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ene 2014

    Estado de capital el 15 ene 2014

    • Capital: GBP 2,090.275536
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    5 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * 4Th Floor Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8LW* el 22 dic 2011

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 19 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr David Leonard Grose el 20 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Alasdair Evans como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ENGLISH PROPERTY CORPORATION?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MEPC SECRETARIES LIMITED
    4th Floor Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8LW London
    Secretario corporativo
    4th Floor Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8LW London
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro429068
    79708020003
    GROSE, David Leonard
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant120479020004
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    c/o Mepc Secretaries Limited
    Portsoken Street
    E1 8HZ London
    1
    England
    Director
    c/o Mepc Secretaries Limited
    Portsoken Street
    E1 8HZ London
    1
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant155163600003
    LEE, John Philip Macarthur
    Flat 9 14 Marylebone Street
    W1M 7PR London
    Secretario
    Flat 9 14 Marylebone Street
    W1M 7PR London
    British32509900003
    PRATT, Dennis Charles
    Firfield 5 Menin Way
    GU9 8DY Farnham
    Surrey
    Secretario
    Firfield 5 Menin Way
    GU9 8DY Farnham
    Surrey
    British3815800001
    PRICE, John Dewi Brychan
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    Secretario
    12 The Rise
    RH16 2TA Lindfield
    West Sussex
    BritishCompany Secretary3041640002
    BATCHELOR, Peter Andrew
    Flat 269 North County Hall
    1c Belvedere Road
    SE1 7GF London
    Director
    Flat 269 North County Hall
    1c Belvedere Road
    SE1 7GF London
    BritishChartered Accountant68594020002
    BEVERIDGE, James Aitchison
    8 La Tourne Gardens
    BR6 8EJ Orpington
    Kent
    Director
    8 La Tourne Gardens
    BR6 8EJ Orpington
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant3037910001
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Director
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Director
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector Taxation100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Director
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Director
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritishDirector-Corporate Property Fi130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Director
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Surveyor33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    38 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    Director
    38 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant93017010003
    MCGARRITY, Stewart
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant65801380001
    MONAGHAN, Kevin Peter
    Pendennis
    High Street, Long Wittenham
    OX14 4QJ Abingdon
    Oxon
    Director
    Pendennis
    High Street, Long Wittenham
    OX14 4QJ Abingdon
    Oxon
    EnglandBritishChartered Surveyor116273610001
    MONIZ, Christopher Mario
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    Director
    26 The Avenue
    CR5 2BN Coulsdon
    Surrey
    EnglandBritishCertified Accountant3831690001
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Director
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritishChartered Accountant155262770001
    SHEPPARD, Colin George
    Moffatt Cottage
    Berry Lane
    WD3 5EU Chorleywood
    Hertfordshire
    Director
    Moffatt Cottage
    Berry Lane
    WD3 5EU Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor213673820001
    STRATTON, Carol Ann
    127 Maidstone Road
    Ruxley Corner Foots Cray
    DA14 5HX Sidcup
    Kent
    Director
    127 Maidstone Road
    Ruxley Corner Foots Cray
    DA14 5HX Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishCompany Secretary79680570001
    THOMPSON, Nathan James
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    Director
    No 1 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HW London
    BritishChartered Surveyor43320980004
    TUCKEY, James Lane
    95 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    Director
    95 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    United KingdomBritishChartered Surveyor35019240001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Director
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accoutant4779170003
    WATTERS, Iain Russell
    Laurel Bank
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham Slough
    Buckinghamshire
    Director
    Laurel Bank
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham Slough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3717820002

    ¿Tiene ENGLISH PROPERTY CORPORATION alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of release and substitution
    Creado el 11 feb 1997
    Entregado el 17 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal of and interest on £10,000,000 9 7/8 percent. First mortgage debenture stock 1997/2002 of the company constituted and secured by a trust deed dated 7TH july 1972 made between the company certain subsidiaries of the company and the trustee and by deeds supplemental thereto including the deed of release and substitution above referred to and all other moneys intended to be secured by such trust deed and the deeds supplemental thereto including such deed of release and substitution
    Breve descripción
    All those premises k/a abbots house abbey street reading t/n BK212357 with all buildings erections fixed plant & machinery landlords fixtures thereon belonging to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 17 feb 1997Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of lease & substitution
    Creado el 19 abr 1988
    Entregado el 21 abr 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,000,000 9 7/8 % first mortgage debenture stock 1997/2002 & all other monies due from the company to the chargee secured by a trust deed dated 7/7/72
    Breve descripción
    The sum of £1,375,000 forming part of the specific security as defined by the trust deed.
    Personas con derecho
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 21 abr 1983Registro de una carga
    Supplemental trust deed
    Creado el 07 mar 1988
    Entregado el 10 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Securing the payment of the principal of and interest on the outstanding £20,000,000 9 3/4 % fist mortgage debenture stock 1997/2002 of mepc PLC and all other moneys due from the company to the chargee under the terms of the deed & various other deeds to which it is supplemental as defined in the deed.
    Breve descripción
    F/H greycoat house, greycoat place, london borough of city of westminister t/n ln 175945 together with all buildings erections, fixed plant fixtuers of fittings and machinery.
    Personas con derecho
    • The Pridential Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 10 mar 1988Registro de una carga
    • 19 sept 1992Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 26 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 30 oct 1987
    Entregado el 05 nov 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal sum and all other monies due or to become due from the company to the chargee on the £10,000,000 1ST mortgage debenture stock 1997/2002 created and secured by a trust deed dated 7/7/72 and deeds supplemental thereto
    Breve descripción
    All those premises known as petershill house, queen victoria street in teh city of london & all buildings & erections fixed plant machinery & land lands fixtures thereon (for full details see form 395).
    Personas con derecho
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 05 nov 1987Registro de una carga
    • 14 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release substituion
    Creado el 05 ago 1986
    Entregado el 13 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10 m 10. 5% first mortgage debenture stock 1983-87 of the company secured by a turst deed dated 17 dec 1970 and all other moneys intended to be secured by deeds supplemental thereto and £5M 15. 75% first mortgage debenture stock 1987 of the company secured by a trsut deed dated 30 dec 1977 and all other moneys intended to be secured by deeds supplemental thereto
    Breve descripción
    L/Hold property k/as kingsmead shopping centre farnborough, rushmoor hampshire title no hp 235680 l/hold land & buildings lying on the west of kingsmead, farnborough rushmoor hampshire title no hp 179106 together (in the case of both properties) with all buildings fixed plant machinery and fixtures (other than tenant's or trade fixtures) thereon.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Trust Company Limited
    Transacciones
    • 13 ago 1986Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 01 nov 1982
    Entregado el 11 nov 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the principal deed dated 26/5/81 as varied by the facility letter dated 25/8/81 and amended by the further facilitiy letter dated 31/3/82
    Breve descripción
    F/H land at clarence st thames st & bishop's hall kingston upon thames surrey known as bishop's palace house title nos sy 312870 sy 304298 sgl 294623.
    Personas con derecho
    • International Westminster Bank Limited
    Transacciones
    • 11 nov 1982Registro de una carga
    • 21 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 jul 1982
    Entregado el 26 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    L/H 112,114,116 old street finsbury islington ln 94524 l/h 44 to 52 (even nos) banner st finsbury ln 170668 & ln 237042 with all buildings fixtures legal charge over rents benefit of any proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • Manufactuers Hanover Trust Compay
    Transacciones
    • 26 jul 1982Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 19 jul 1982
    Entregado el 26 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chargee
    Breve descripción
    F/H land in queen street barnstaple in the county of north devon together with the building erected thereon or some part therof and known as princess house, queen street barnstaple. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transacciones
    • 26 jul 1982Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 19 jul 1982
    Entregado el 26 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from salimex ag egnach under the terms of an agreement dated 8 july 1982. to the chargee
    Breve descripción
    F/H land 417 and 419 sutton road, southend on sea, essex title no ex 235474. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Manufacturer Hanover Trust Company
    Transacciones
    • 26 jul 1982Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 19 jul 1982
    Entregado el 26 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from salimex ag egnach to the chargee under the terms of an agreement dated 8 july 1982
    Breve descripción
    F/H land and building in drury lane, macklin street, and parker street holborn london borough of camden title no ngl 36377. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transacciones
    • 26 jul 1982Registro de una carga
    • 21 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 jul 1982
    Entregado el 26 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chragee under the terms of an agreement dated 8/7/8I
    Breve descripción
    L/H known as concord house, 454,456 and 458 london road, croydon, greater london, title no sg 1236755. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transacciones
    • 26 jul 1982Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 17 jul 1982
    Entregado el 26 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from salimex ag egnach to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    L/H property the beeches, 42 to 68 market place nottingham road long eaton erewash title no dy 53752 with all buildings fixtures etc legal charge over rents bennefit of all proceeds of sale threof.
    Personas con derecho
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transacciones
    • 26 jul 1982Registro de una carga
    Deed of substituion
    Creado el 18 ene 1982
    Entregado el 02 feb 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever was registered pursuant to section 95 companies act 1948 on the 2/2/82
    Breve descripción
    L/H holland house, 120/21, pall mall in the city of westminster registered at H.M. land registry title no 422732 and l/h land at 21, college hill, london registered at H.M. land registry title no ln 86667.
    Personas con derecho
    • International Westminister Bank Limited
    Transacciones
    • 02 feb 1982Registro de una carga
    • 21 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creado el 11 nov 1981
    Entregado el 13 nov 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For further securing £1,025,00072 % first mortgage debenture stock 1992-1997 o fthe company securet by the principal deed deated 13/2/67 and deeds supplemental thereto.
    Breve descripción
    F/H 44-58 -even nos) charles street, 5,7 & 9A, york street & the sites of 7 & 11, york street, chorlton-on-medlock with the buildings on whole or part thereof known as bracken house, title no. La 6708, f/h 26,26A,26B,26C & 27A fore street and 26, corporatin street, taunton, taunton deane borough council, somerset.
    Personas con derecho
    • Paul Accurance Company Limited
    Transacciones
    • 13 nov 1981Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 26 may 1981
    Adquirido el 29 jun 1984
    Entregado el 19 jul 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,000,000
    Breve descripción
    Redwell house, bell lane, london E1 title no: ln 77541.
    Personas con derecho
    • International Westminster Bank Limited
    Transacciones
    • 19 jul 1984Registro de una carga
    • 21 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 26 may 1981
    Adquirido el 19 abr 1985
    Entregado el 28 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,000
    Breve descripción
    Market gates shopping centre at yarmouth norfolk title no nk 16118.
    Personas con derecho
    • International Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 abr 1982Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 26 may 1981
    Entregado el 03 jun 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    L/H - lee house, london wall, london, EC2 titl eno's ln 222195 & ln 222366 f/h- land in drury lane macklin st, and parker st, holborn, london borough of camden title no ngl 36377.
    Personas con derecho
    • Internatinal Westminster Bank Limited
    Transacciones
    • 03 jun 1981Registro de una carga
    • 21 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creado el 07 may 1981
    Entregado el 13 may 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The principal amount of first mortgage debenture stock 1992/97 & all other monies intended to be secured by a trust deed dated 13.2.67 and deeds supplemetal thetreto
    Breve descripción
    48,50, & 51 floral street & passageway between 49 and 50 floral street london.
    Personas con derecho
    • Pearl Assurance Comapny Limited
    Transacciones
    • 13 may 1981Registro de una carga
    Deed of release & subsitution
    Creado el 18 sept 1980
    Entregado el 23 sept 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,000,000 11 1/2 % first mortgage & debenture stock 1982 of the company secured by a trust deed dated 30/12/77 and supplemental trust deed dated 29/12/78 together with, all interst and other monies thereby secured
    Breve descripción
    L/H kingsmead centre, phase ii farnborough, hampshire.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Trust Company Limited
    Transacciones
    • 23 sept 1980Registro de una carga
    Deed of guarantee and legal mortgage dated
    Creado el 15 ago 1980
    Entregado el 19 ago 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the international finance S.A. to international westminster bank limited under the terms of an agreement dated 31/10/73
    Breve descripción
    Lee house london wall london EC2 title no ln 222195 and ln 222366.
    Personas con derecho
    • International Westminster Bank Limited
    Transacciones
    • 19 ago 1980Registro de una carga
    • 21 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 abr 1980
    Entregado el 01 may 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    454,456 & 458 london rd croydon, surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 may 1980Registro de una carga
    Deed of release and substitution
    Creado el 07 mar 1980
    Entregado el 10 mar 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £1,000,000 6 1/2% 1ST mortgage debenture stock 1978/83 of 2ND covant garden property company LTD and all other monies due under the terms of trust deed dated 22/07/58 and deeds supplemental thereto.
    Breve descripción
    F/Hold property:-48, 50 and 59 floral street title no ngl 321822.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Insurance Company
    Transacciones
    • 10 mar 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 07 feb 1980
    Adquirido el 19 nov 1979
    Entregado el 07 feb 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £400,000
    Breve descripción
    Property in colyear street & macklin street,derby.
    Personas con derecho
    • The Scottish Widows Fund and Life Assurance Society
    Transacciones
    • 07 feb 1980Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 16 jul 1979
    Adquirido el 28 may 1980
    Entregado el 31 may 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £711,200
    Breve descripción
    417/419 sutton road southend on sea essex.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transacciones
    • 31 may 1980Registro de una carga
    Deed of release & subsitution
    Creado el 13 mar 1979
    Entregado el 15 may 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £10,000,000 9 7/8 first mortgage debenture stock of the company secured by a trust deed dated 7 july 1972 and deeds supplemental thereto.
    Breve descripción
    All those premises known as crest house and petershill house queen victoria street, london title no ln 240584.
    Personas con derecho
    • Alliance Assurance Company LTD
    Transacciones
    • 15 may 1979Registro de una carga
    • 14 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ENGLISH PROPERTY CORPORATION algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 sept 2016Inicio de la liquidación
    21 dic 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Profesional
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0