ZENITH PLUMBPOINT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ZENITH PLUMBPOINT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00640740 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O MAZARS LLP 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HEATEK LABONE LIMITED | 15 nov 1991 | 15 nov 1991 |
| HEATEK SERVICES LIMITED | 29 oct 1959 | 29 oct 1959 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT a 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX el 21 abr 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Lodge Way House Lodge Way Harlstone Road Northampton NN5 7UG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT el 25 sept 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 01 jul 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Deborah Grimason como director el 06 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Peter Carter como director el 18 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Deborah Grimason como director el 18 jul 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony David Buffin como director el 11 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alan Richard Williams como director el 11 jul 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 1 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Alan Richard | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Director corporativo | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| BAKER, John Edgar | Secretario | Old Barn House Yorkley GL15 4RX Lydney Gloucestershire | British | 62612550001 | ||||||||||
| BALL, Ute Suse | Secretario | Fleet House Lee Circle LE1 3QQ Leicester | British | 118371550001 | ||||||||||
| EASTWOOD, Jeremy Colin | Secretario | 10 Broad Close Barford St Michael OX15 0RW Banbury Oxfordshire | British | 40739950001 | ||||||||||
| HAMMOND, Geoffrey Byard | Secretario | 273 London Road LE2 3BE Stoneygate Leicestershire | British | 122820710001 | ||||||||||
| HIGGINSON, Kevin Mark | Secretario | The Beeches, Myrtle Lodge Farm Main Street LE65 2TY Smisby Leicestershire | British | 116296480001 | ||||||||||
| JOHNS, David | Secretario | 10 Pantain Road LE11 3NA Loughborough Leicestershire | British | 639840001 | ||||||||||
| MURRAY, John Roderick | Secretario | Flat 1 26 Sumburgh Road SW12 8AJ London | British | 145111310001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Secretario | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | 158160310001 | |||||||||||
| BAKER, John Edgar | Director | Old Barn House Yorkley GL15 4RX Lydney Gloucestershire | United Kingdom | British | 62612550001 | |||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| COOPER, Peter | Director | 1 Brook Terrace Medbourne LE16 8DN Market Harborough Leicestershire | British | 14466860001 | ||||||||||
| DONOVAN, Patrick Wallace | Director | Long Acre College Street LE17 5BU Ullusthorpe Leicestershire | England | British | 89392800001 | |||||||||
| GRIMASON, Deborah | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House | England | British | 185755960002 | |||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HIGGINSON, Kevin Mark | Director | The Beeches, Myrtle Lodge Farm Main Street LE65 2TY Smisby Leicestershire | United Kingdom | British | 116296480001 | |||||||||
| HOWROYD, Michael Stanley | Director | Woodvine House Tewkesbury Road Twigworth GL2 9PX Gloucester Gloucestershire | British | 67367050001 | ||||||||||
| LEE, Robert Scott | Director | 32 Grove Road Coombe Dingle BS9 2RL Bristol Avon | British | 14861680001 | ||||||||||
| MILNE, Alan Douglas | Director | 79 Carisbrooke Road LE2 3PF Leicester Leicestershire | British | 65893230001 | ||||||||||
| MURRAY, John Roderick | Director | Fleet House Lee Circle LE1 3QQ Leicester | United Kingdom | British | 145111310001 | |||||||||
| SLARK, Gavin | Director | Fleet House Lee Circle LE1 3QQ Leicester | United Kingdom | British | 162972090001 | |||||||||
| WOOD, Peter Scott | Director | 31 Newall Hall Park LS21 2RD Otley West Yorkshire | British | 1732940001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bss Group Limited | 06 abr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ZENITH PLUMBPOINT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Chattels mortgage | Creado el 27 nov 1987 Entregado el 30 nov 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All and singular the chattels plant machinery & items one ford cargo phi 1313 & registration number E648 kfb chassis number cxxccdchy 85277 together with ratcliffe tailifr rq 1003 and crane. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattels mortgage | Creado el 21 oct 1987 Entregado el 22 oct 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All and singular the chattels, plant machinery and items one new ford cargo phi chassis number cc d chy 85329 registration number E647 kfb. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge without instrument | Creado el 28 ago 1984 Entregado el 06 sept 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H premises k/a wheeler house, colchester avenue cardiff together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the said premises. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge without instrument | Creado el 28 ago 1984 Entregado el 06 sept 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H premises k/a wheeler house, colchester avenue. Cardiff together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the said premises. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 10 sept 1982 Entregado el 15 sept 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All book debts & other debts now & from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 10 sept 1982 Entregado el 15 sept 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H lying to the north west of st oswalds road, gloucester T.N. gr 48226. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 10 sept 1982 Entregado el 15 sept 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H lying to the north west of st. Oswalds road, gloucester, T.N. gr 59540. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 20 nov 1972 Entregado el 23 nov 1972 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Factory and premises at abbey road, hempstead, glos. And all fixtures. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage and charge | Creado el 14 dic 1959 Entregado el 31 dic 1959 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due etc | |
Breve descripción Freehold lands known as coalway lane end, nr coalway west dean, gloucs and land adjoining with buildings therein present & future undertaking and all property and present and future including uncalled capital (for details see doc 8). together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene ZENITH PLUMBPOINT LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0