EXSIMPIL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEXSIMPIL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00640930
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EXSIMPIL LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra EXSIMPIL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EXSIMPIL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SIMPLEX PILING LIMITED30 oct 195930 oct 1959

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EXSIMPIL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EXSIMPIL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 14 may 2013

    • Capital: GBP 88,247
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    5 páginasAA

    Nombramiento de John William Young Strachan Samuel como director

    3 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2008

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2007

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de EXSIMPIL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Director
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Director corporativo
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARD, Paul William
    6 Hampden Close
    North Weald
    CM16 6JX Epping
    Essex
    Secretario
    6 Hampden Close
    North Weald
    CM16 6JX Epping
    Essex
    British74177720001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Secretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BAKER, Anthony Charles
    30 Wilkinson Close
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    Director
    30 Wilkinson Close
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    British20808860001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Director
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BISHOP, Michael John
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British11164490003
    BOLSHER, Terence
    The Hop House
    Fields Courtyard
    DN22 Grove Retford
    Notts
    Director
    The Hop House
    Fields Courtyard
    DN22 Grove Retford
    Notts
    British10374150001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish61631390001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Director
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Director
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Director
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritish87102720001
    HOLROYD, Thomas Harry
    James House 1 Jacks Lane
    Marchington
    ST14 8LW Uttoxeter
    Staffordshire
    Director
    James House 1 Jacks Lane
    Marchington
    ST14 8LW Uttoxeter
    Staffordshire
    British36692470001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Director
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    British1729130003
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Director
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    SMITH, Steven David
    10 Woodgate Close
    Charlton Kings
    GL52 6UW Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    10 Woodgate Close
    Charlton Kings
    GL52 6UW Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish65590120001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Director
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    British51937070001
    WILKINS, Alan John
    11 Blacksmith Drive Grove Green
    Weavering
    ME14 5SZ Maidstone
    Kent
    Director
    11 Blacksmith Drive Grove Green
    Weavering
    ME14 5SZ Maidstone
    Kent
    British3052320001
    WOOLFE, Jonathan Michael David
    98 Deepwell Avenue
    Halfway
    S20 4ST Sheffield
    Director
    98 Deepwell Avenue
    Halfway
    S20 4ST Sheffield
    British62130320001

    ¿Tiene EXSIMPIL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattel mortgage
    Creado el 18 dic 1998
    Entregado el 21 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £274,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Breve descripción
    New junttan PM20LC piling rig s/no.1189.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage
    Creado el 01 dic 1998
    Entregado el 04 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £200,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    On casagrande B150E piling rig-serial no.c/103063-00 with concrete pumping system and all other component parts,accessories,improvements and renewals.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 04 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 ago 1997
    Entregado el 02 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 16 nov 1995
    Entregado el 21 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 nov 1993
    Entregado el 18 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property land on the south side of garage lane setchley norfolk title no NY91815 and the proceeds of sale tog with the full benefit of all licences including any registrations.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0