TATHAM STEELS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | TATHAM STEELS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00641459 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TATHAM STEELS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TATHAM STEELS LIMITED?
Dirección de la sede social | 88 Wood Street EC2V 7QF London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TATHAM STEELS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
TATHAM & CO.(H.MILLER)LIMITED | 06 nov 1959 | 06 nov 1959 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TATHAM STEELS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TATHAM STEELS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 40 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 abr 2019 | 36 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Duke Avenue Duke Avenue Cheadle Hulme Cheadle Cheshire SK8 6QZ England a 88 Wood Street London EC2V 7QF el 23 may 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notification de Tatham Miller Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Mbm Group Services Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Simmons Gainsford Llp 7-10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ a Duke Avenue Duke Avenue Cheadle Hulme Cheadle Cheshire SK8 6QZ el 17 jul 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Watson como director el 08 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Anthony Welden como director el 19 mar 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Citypoint One Ropemaker Street London EC2Y 9ST a C/O Simmons Gainsford Llp 7-10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ el 13 abr 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nicholas Watson como director el 27 feb 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Gerard Broom como director el 27 feb 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alastair Macphie como director el 27 feb 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Amanda Louise Phillips como secretario el 31 jul 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TATHAM STEELS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPHIE, Alastair Murdoch | Director | Wood Street EC2V 7QF London 88 | Scotland | British | Accountant | 175562920001 | ||||
WELDEN, Michael Anthony | Director | Wood Street EC2V 7QF London 88 | United Kingdom | British | None | 190432390001 | ||||
BRADBURN, Paul Patrick | Secretario | 6 Liff Gardens Bishopbriggs G64 1XN Glasgow Lanarkshire | British | 8344710001 | ||||||
CHANCE, Myles Geoffrey | Secretario | Ashlawn 21 Eyebrook Road Bowdon WA14 3LH Altrincham Cheshire | British | 3447810001 | ||||||
GOLDSMITH, Andrew Stanley | Secretario | Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9ST London Level 27, England | 151374800001 | |||||||
PHILLIPS, Amanda Louise | Secretario | One Ropemaker Street EC2Y 9ST London Citypoint England | 161224920001 | |||||||
PHILLIPS, Amanda Louise | Secretario | Karina Close IG7 4EN Chigwell 32 Essex | British | Chartered Secretary | 88965110002 | |||||
BAYLIS, Alan | Director | 5 Longnor Road Heald Green SK8 3BW Cheadle Cheshire | British | Director | 3447820001 | |||||
BRADBURN, Paul Patrick | Director | 6 Liff Gardens Bishopbriggs G64 1XN Glasgow Lanarkshire | British | Accountant | 8344710001 | |||||
BROOM, Michael Gerard | Director | One Ropemaker Street EC2Y 9ST London Citypoint England | United Kingdom | New Zealander | Finance Director | 68759080002 | ||||
BROWN, John David | Director | 25 Thornhill Road Heaton Mersey SK4 3HL Stockport Cheshire | British | Director | 3447830001 | |||||
CHANCE, Myles Geoffrey | Director | Ashlawn 21 Eyebrook Road Bowdon WA14 3LH Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Director | 3447810001 | ||||
EVERETT, Howard Caile | Director | 27 Newton Road Knowle B93 9HL Solihull West Midlands | British | Director | 3447840001 | |||||
GOLDSMITH, Andrew Stanley | Director | One Ropemaker Street EC2Y 9ST London Citypoint England | England | British | Solicitor | 73440100002 | ||||
JOHNSON, Eric | Director | Glenmorie Racecourse Lane DY8 2RL Stourbridge West Midlands | British | Director | 3447850001 | |||||
SARA, Michael Edward | Director | Hillbarn Rectory Lane DY13 0TB Stourport On Severn Worcestershire | British | Director | 56778390002 | |||||
SMITH, Roderick James Anthony | Director | One Ropemaker Street EC2Y 9ST London Citypoint England | England | British | Tax Manager | 13599130001 | ||||
WALKER, James | Director | 26 Lampson Road Killearn G63 9PD Glasgow | British | Chartered Accountant | 1111020001 | |||||
WATSON, Nicholas Daniel | Director | c/o Simmons Gainsford Llp Chandos Street Cavendish Square W1G 9DQ London 7-10 | United Kingdom | British | Solicitor | 129701280002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TATHAM STEELS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbm Group Services Ltd | 06 abr 2016 | Chandos Street W1G 9DQ London 7-10 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Tatham Miller Ltd | 06 abr 2016 | Stanley Green Industrial Estate Cheadle Hulme SK8 6QZ Cheadle Duke Avenue England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene TATHAM STEELS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 09 abr 1998 Entregado el 22 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
First party commercial legal charge | Creado el 09 abr 1998 Entregado el 17 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land and buildings at duke avenue stanley green cheadle house cheadle hume cheshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 27 jul 1987 Entregado el 31 jul 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from totham millax limited the chargee. | |
Breve descripción F/H property k/a land in stanley road cheadle hulme cheadle cheshire and the proceeds of sale thereof (see doc M229/31 july/ln for details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 01 abr 1970 Entregado el 22 abr 1970 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene TATHAM STEELS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0