DECKCHAIR STUDIO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DECKCHAIR STUDIO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00644752 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DECKCHAIR STUDIO LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DECKCHAIR STUDIO LIMITED?
| Dirección de la sede social | 27 Farm Street London W1J 5RJ |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DECKCHAIR STUDIO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AGE SYNERGY LIMITED | 17 dic 1959 | 17 dic 1959 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DECKCHAIR STUDIO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DECKCHAIR STUDIO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steve Richard Winters como director el 14 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Grant Balfour Scott como director el 12 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2017 au 30 jun 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Steve Winters como director el 06 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Paul Sweetland como director el 01 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Wpp Group (Nominees) Limited el 27 mar 2014 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Estado de capital el 23 dic 2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DECKCHAIR STUDIO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Secretario corporativo | 27 Farm Street W1J 5RJ London |
| 80143770001 | ||||||||||
| WELLE, Charles Ward Van Der | Director | 27 Farm Street London W1J 5RJ | United Kingdom | British | 181492230001 | |||||||||
| CALOW, David Ferguson | Secretario | 27 Farm Street W1J 5RJ London | British | 91285750001 | ||||||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secretario | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||||||
| JANS, Annamaria | Secretario | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Secretario | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Denise | Secretario | Marie Cottage Holmbury Lane RH5 6ND Holmbury St Mary Surrey | British | 24311940004 | ||||||||||
| BINDING, David Wyn | Director | 48 Midhurst Avenue Muswell Hill N10 3EN London | British | 5994480001 | ||||||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Director | 25 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 71264540005 | ||||||||||
| BUSS, Jeremy David | Director | 34 Goddington Road SL8 5TZ Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | 26720550002 | |||||||||
| DELANEY, Paul | Director | 27 Farm Street W1J 5RJ London | United Kingdom | British | 69254240002 | |||||||||
| HAM, David Fenton | Director | 25 Chestnut Avenue TN4 0BT Tunbridge Wells Kent | England | British | 103819950001 | |||||||||
| HOWARD, Stuart Michael | Director | 2 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||||||
| HOWELL, Peter Graham | Director | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||||||
| JANS, Annamaria | Director | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul Winston George | Director | 125 Park Avenue New York Ny 10017-5529 Usa | British | 45700660003 | ||||||||||
| SCOTT, Andrew Grant Balfour | Director | 27 Farm Street W1J 5RJ London | United Kingdom | British | 67078370001 | |||||||||
| SWEETLAND, Christopher Paul | Director | 27 Farm Street W1J 5RJ London | England | British | 56529540005 | |||||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Director | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Director | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Denise | Director | Marie Cottage Holmbury Lane RH5 6ND Holmbury St Mary Surrey | British | 24311940004 | ||||||||||
| WILSON, Stephen Michael | Director | 9 Boulters Lock Giffard Park MK14 5QR Milton Keynes | British | 81144620001 | ||||||||||
| WINTERS, Steve Richard | Director | 27 Farm Street London W1J 5RJ | England | British | 210160610001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DECKCHAIR STUDIO LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordiant Communications Group Limited | 06 abr 2016 | Farm Street W1J 5RJ London 27 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene DECKCHAIR STUDIO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creado el 19 abr 2002 Entregado el 26 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 04 abr 2002 Entregado el 12 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 dic 1997 Entregado el 24 dic 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same became due for payment or discharge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Equitable mortgage. | Creado el 02 ago 1971 Entregado el 03 ago 1971 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due under the terms of a facility letter dated 30TH july 1971 | |
Breve descripción L/H premises at 19/23 grosvenor hill london. W.1. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0