UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED

UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUNION PROPERTY CORPORATION LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00664862
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2025
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta11 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence25 jul 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta11 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024

    6 páginasAA

    Nombramiento de Alexander Christofis como director el 22 dic 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nick Taunt como director el 22 dic 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 30 jun 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Charles John Middleton como director el 31 mar 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul Case como director el 17 mar 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 18 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    20 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Nigel Mark Webb el 04 jul 2019

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 31 mar 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 19 ene 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    18 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro8992198
    187856670001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    CASE, Paul
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishDevelopment Director294078290001
    CHRISTOFIS, Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishShared Services Director294162810001
    MACEY, Paul Stuart
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant205652070001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Director
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Director
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary189931090001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Director
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Director
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    VAN DER MAREL, Arend Johannes
    Keizersgracht 208
    FOREIGN Amsterdam
    1016 Dx
    The Netherlands
    Director
    Keizersgracht 208
    FOREIGN Amsterdam
    1016 Dx
    The Netherlands
    DutchManaging Director58883520001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director170947050001
    WEBB, Nigel Mark
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishHead Of Developments58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Director
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    WILSON, Alan James
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    Director
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant3078220001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bl Retail Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    31 dic 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro05995033
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A security agreement
    Creado el 23 nov 2010
    Entregado el 01 dic 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all estates or interests; and all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery in the real property see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Landesbank, London Branch
    Transacciones
    • 01 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    Scottish assignation in security
    Creado el 24 mar 1999
    Entregado el 26 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obigations monies and liabilities due or owing or incurred to the royal exchange trust company limited by the obligants under the trust deed
    Breve descripción
    The companys whole right title interest and benefit in and to the trust agreement together with all rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 26 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 ene 1997
    Entregado el 07 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,475 and all other sums due from the company to the chargee in accordance with clause 5 of the sale contract dated 31ST december 1996 (as defined) and any costs pursuant to clause 15 of the legal charge
    Breve descripción
    F/Hold land and buildings on the north and south sides of godfrey way,feltham,hounslow; t/no agl 40101.
    Personas con derecho
    • Bull Information Systems Limited
    Transacciones
    • 07 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 18 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First supplemental trust deed
    Creado el 19 dic 1995
    Entregado el 04 ene 1996
    Fecha del instrumento de cobertura 19 dic 1995
    Pendiente
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limitedthe "Trustee"
    Transacciones
    • 04 ene 1996Registro de una carga para asegurar una serie de debentures (397)
    • 10 oct 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 22 mar 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Trust deed
    Creado el 06 oct 1995
    Entregado el 20 oct 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the trust deed) whether or not of the same series and all other moneys payable by the issuer to the trustee (as defined in the trust deed) under the terms of the trust deed
    Breve descripción
    169/195 (odd no'S.) botley road oxford t/n ON99443 torther with all buildings erections fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limitedthe "Trustee"
    Transacciones
    • 20 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0