UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00664862 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?
Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jul 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 25 jul 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jul 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024 | 6 páginas | AA | ||
Nombramiento de Alexander Christofis como director el 22 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nick Taunt como director el 22 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Charles John Middleton como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Paul Case como director el 17 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 18 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 20 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Nigel Mark Webb el 04 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 20 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 19 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 18 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
CASE, Paul | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Development Director | 294078290001 | ||||||||
CHRISTOFIS, Alexander | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Shared Services Director | 294162810001 | ||||||||
MACEY, Paul Stuart | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 205652070001 | ||||||||
MCNUFF, Jonathan Charles | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205624050001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Secretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Secretario | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Chartered Accountant | 32809050044 | ||||||||
BERRY, David Charles | Director | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 166550001 | |||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Director | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
GUNSTON, Michael Ian | Director | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3079890002 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
KALMAN, Stephen Lionel | Director | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | Chartered Surveyor | 1188110001 | ||||||||
METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||||||
MIDDLETON, Charles John | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Tax Executive | 79841030002 | ||||||||
PENRICE, Victoria Margaret | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Secretary | 189931090001 | ||||||||
RITBLAT, John, Sir | Director | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman Managing Director | 41694870001 | ||||||||
RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Director | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | Company Director | 35758050004 | ||||||||
ROBERTS, Graham Charles | Director | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
SMITH, Stephen Paul | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||||||
TAUNT, Nick | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 275050860001 | ||||||||
VAN DER MAREL, Arend Johannes | Director | Keizersgracht 208 FOREIGN Amsterdam 1016 Dx The Netherlands | Dutch | Managing Director | 58883520001 | |||||||||
VANDEVIVERE, Jean-Marc | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | Company Director | 170947050001 | ||||||||
WEBB, Nigel Mark | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Head Of Developments | 58059360001 | ||||||||
WESTON SMITH, John Harry | Director | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | Chartered Secretary | 13547380001 | ||||||||
WILSON, Alan James | Director | 30 Broxbourne Road BR6 0AY Orpington Kent | England | British | Chartered Accountant | 3078220001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bl Retail Holding Company Limited | 31 dic 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene UNION PROPERTY CORPORATION LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Creado el 23 nov 2010 Entregado el 01 dic 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all estates or interests; and all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery in the real property see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Scottish assignation in security | Creado el 24 mar 1999 Entregado el 26 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All obigations monies and liabilities due or owing or incurred to the royal exchange trust company limited by the obligants under the trust deed | |
Breve descripción The companys whole right title interest and benefit in and to the trust agreement together with all rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 02 ene 1997 Entregado el 07 ene 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £3,475 and all other sums due from the company to the chargee in accordance with clause 5 of the sale contract dated 31ST december 1996 (as defined) and any costs pursuant to clause 15 of the legal charge | |
Breve descripción F/Hold land and buildings on the north and south sides of godfrey way,feltham,hounslow; t/no agl 40101. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
First supplemental trust deed | Creado el 19 dic 1995 Entregado el 04 ene 1996 Fecha del instrumento de cobertura 19 dic 1995 | Pendiente | ||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 06 oct 1995 Entregado el 20 oct 1995 | Pendiente | Cantidad garantizada 250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the trust deed) whether or not of the same series and all other moneys payable by the issuer to the trustee (as defined in the trust deed) under the terms of the trust deed | |
Breve descripción 169/195 (odd no'S.) botley road oxford t/n ON99443 torther with all buildings erections fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0