DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00668770 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED?
Dirección de la sede social | 350 Euston Road NW1 3AX London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ST. REGIS PACKAGING LIMITED | 30 abr 1993 | 30 abr 1993 |
DAVID S. SMITH PACKAGING LIMITED | 18 feb 1988 | 18 feb 1988 |
TILLOTSONS CORRUGATED CASES (MONMOUTH) LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
PREMIER BOX COMPANY LIMITED (THE) | 29 ago 1960 | 29 ago 1960 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2019 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anne Steele como director el 31 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Zillah Wendy Stone como director el 31 oct 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anne Steele como secretario el 31 oct 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Zillah Wendy Stone como secretario el 31 oct 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2018 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr William Beverley Hicks el 25 jul 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2017 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Paul Jowett como director el 21 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr William Beverley Hicks como director el 21 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de David Matthews como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Beech House Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road Maidenhead Berkshire SL6 8XY* el 20 nov 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STONE, Zillah Wendy | Secretario | Euston Road NW1 3AX London 350 | 252468530001 | |||||||
HICKS, William Beverley | Director | Euston Road NW1 3AX London 350 | United Kingdom | British | Company Director | 132456870003 | ||||
STONE, Zillah Wendy | Director | Euston Road NW1 3AX London 350 | United Kingdom | British | Company Secretary | 55643660001 | ||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Secretario | 81 Cranbrook Road Chiswick W4 2LJ London | British | Company Secretary | 53026290001 | |||||
RICHARDSON, Alan John | Secretario | 118 Paxford Road Sudbury Court HA0 3RH North Wembley Middlesex | British | 43179370001 | ||||||
RUSSELL, John Stuart | Secretario | Hundred Lodge 25 The Forebury CM21 9BD Sawbridgeworth Hertfordshire | British | 480230001 | ||||||
STEELE, Anne | Secretario | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | British | 77624110001 | ||||||
BRASH, Jeremy Patrick Irving | Director | Rose Cottage Deanland SP5 5PD Sixpenny Handley Dorset | British | Director | 39788740001 | |||||
BUTTFIELD, David Frank | Director | Mill Meadow Mill Lane HP7 0EH Amersham Buckinghamshire | British | Accountant | 37624090002 | |||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Director | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | United Kingdom | British | Company Executive | 53026290002 | ||||
DRYDEN, Stephen William | Director | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | England | British | Company Director | 47821400004 | ||||
GREEN, Michael George | Director | Thorniethwaite DG11 1JH Lockerbie Dumfries | Scotland | British | Director | 23613980001 | ||||
JOWETT, Matthew Paul | Director | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | England | British | Company Director | 205867540001 | ||||
MATTHEWS, David John | Director | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | England | British | Accountant | 101577480001 | ||||
MORRIS, Gavin Mathew | Director | 20 Argyll Road W8 7BG London | England | British | Company Executive | 16228990001 | ||||
ROBERTS, Miles William | Director | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | England | British | Company Director | 57880630003 | ||||
RUSSELL, John Stuart | Director | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | Company Secretary | 480230002 | |||||
STEELE, Anne | Director | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 77624110001 | ||||
STONE, Michael John | Director | The Cider House Buckland Abbey PL20 6EZ Yelverton Devon | United Kingdom | British | Director | 18200900001 | ||||
THORNE, Anthony David | Director | Whitebrook Park 68 Lower Cookham Road SL6 8XY Maidenhead Beech House Berkshire | United Kingdom | British | Company Executive | 40130640001 | ||||
WILLIAMS, John Peter | Director | 30 Egerton Crescent SW3 2EB London | United Kingdom | British | Director | 707720002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DAVID S SMITH (PENSION CONTRIBUTIONS) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ds Smith Holdings Limited | 06 abr 2016 | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0