DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED

DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00670530
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit A
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARLTON PLASTICS LIMITED21 sept 196021 sept 1960

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2021

    7 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2020

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Thomas James Piper como secretario el 01 jul 2019

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Cameron John Olsen como secretario el 01 jul 2019

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Alastair Peter Orford Dick el 01 may 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Alastair Peter Orford Dick como director el 14 mar 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rachel Isabel Lilian Stockton como director el 14 mar 2019

    1 páginasTM01

    Cessation de Dunlop Slazenger International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 dic 2016

    1 páginasPSC07

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2018

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2017

    7 páginasAA

    Comptes modifiés pour une société dormante établis au 30 abr 2016

    7 páginasAAMD

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones

    7 páginasCS01

    Nombramiento de Miss Rachel Isabel Lilian Stockton como director el 14 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Michael Forsey como director el 14 oct 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Adedotun Ademola Adegoke como director el 14 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael James Wallace Ashley como director el 14 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016

    2 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PIPER, Thomas James
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Secretario
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    260022020001
    ADEGOKE, Adedotun Ademola
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Director
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritish203129860001
    DICK, Alastair Peter Orford
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Director
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritish256598390002
    MARCHETTI, Carlo Antonio
    Glenwood Woodland Rise
    TN15 0HZ Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    Glenwood Woodland Rise
    TN15 0HZ Sevenoaks
    Kent
    British1229580001
    MELLORS, Robert Frank
    The Warrener
    Warren Row
    RG10 8QS Reading
    Berkshire
    Secretario
    The Warrener
    Warren Row
    RG10 8QS Reading
    Berkshire
    British30104540002
    MOODIE, Gordon Murray
    1 Forest Lodge
    Epsom Road
    KT21 1JX Ashtead
    Surrey
    Secretario
    1 Forest Lodge
    Epsom Road
    KT21 1JX Ashtead
    Surrey
    British66078560001
    OLSEN, Cameron John
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Secretario
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    183493780001
    RITCHIE, Alistair John, Sol
    Waterman's Lodge
    15 Beales Lane
    KT13 8JS Weybridge
    Surrey
    Secretario
    Waterman's Lodge
    15 Beales Lane
    KT13 8JS Weybridge
    Surrey
    British6417760002
    SIMPSON, Brian Charles
    15 Langham Way
    RG10 8AX Wargrave
    Berkshire
    Secretario
    15 Langham Way
    RG10 8AX Wargrave
    Berkshire
    British47141350001
    TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Secretario
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    British131967270001
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    Secretario corporativo
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    75491680001
    ASHLEY, Michael James Wallace
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Director
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    EnglandBritish95500210002
    AUSTEN, Patrick George
    14 Chantry View Road
    GU1 3XR Guildford
    Surrey
    Director
    14 Chantry View Road
    GU1 3XR Guildford
    Surrey
    British55015730001
    BRANSON, David Reid
    104 Smilax Court
    Greenville
    South Carolina
    Usa
    Director
    104 Smilax Court
    Greenville
    South Carolina
    Usa
    American49245480001
    BROWN, Robert Casson
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    Director
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    British6343100001
    FORSEY, David Michael
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Director
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    EnglandBritish147207580002
    JACOBS, David Michael
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    Director
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    British47141160001
    LOVELL, Alan Charles
    The Palace House
    Bishops Lane
    SO32 1DP Bishops Waltham
    Hampshire
    Director
    The Palace House
    Bishops Lane
    SO32 1DP Bishops Waltham
    Hampshire
    EnglandBritish149625410001
    MARCHETTI, Carlo Antonio
    Glenwood Woodland Rise
    TN15 0HZ Sevenoaks
    Kent
    Director
    Glenwood Woodland Rise
    TN15 0HZ Sevenoaks
    Kent
    British1229580001
    MARNOCH, Alasdair, Mr.
    Bramble Bottom
    Wedmans Lane
    RG27 9BX Rotherwick
    Hampshire
    Director
    Bramble Bottom
    Wedmans Lane
    RG27 9BX Rotherwick
    Hampshire
    EnglandBritish216655900001
    MELLORS, Robert Frank
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Director
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritish30104540005
    MOODIE, Gordon Murray
    1 Forest Lodge
    Epsom Road
    KT21 1JX Ashtead
    Surrey
    Director
    1 Forest Lodge
    Epsom Road
    KT21 1JX Ashtead
    Surrey
    British66078560001
    PARNELL, Philip John
    The Old Bell House
    The Common
    HP10 8LQ Penn
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Bell House
    The Common
    HP10 8LQ Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish57485400001
    RONNIE, Christopher
    18 Macclesfield Road
    SK9 2AA Wilmslow
    Cheshire
    Director
    18 Macclesfield Road
    SK9 2AA Wilmslow
    Cheshire
    British79360390001
    STOCKTON, Rachel Isabel Lilian
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Director
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    United KingdomBritish245592990001
    THOM, James Demmink
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    Director
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    British38683120002
    WILLIAMS, Stanley Killa
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    Director
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish34401400001
    WRAGG, James Philip
    The Old Vicarage
    CV35 0HD Gaydon
    Warwickshire
    Director
    The Old Vicarage
    CV35 0HD Gaydon
    Warwickshire
    British77836880001
    WYCHERLEY, Peter
    394 Barnsley Road
    Sandal
    WF2 6BW Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    394 Barnsley Road
    Sandal
    WF2 6BW Wakefield
    West Yorkshire
    British130910001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    16 dic 2016
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro10463051
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Brook Park East
    NG20 8RY Shirebrook
    Unit A
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00776384
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene DAVID GEOFFREY & ASSOCIATES (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture
    Creado el 04 abr 1996
    Entregado el 19 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents (as defined in the charge) and all monies due or to become due from pixelframe limited (now renamed dunlop slazenger group limited) (newco) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed) under or in connection with the vendor a note (as therein defined) including the guarantee liabilities of the company to pay all monies due to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note
    Breve descripción
    F/H land forming part of the property k/a plots 4 and 7 shire hill industrial estate saffron walden essex. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 23 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 may 1984
    Entregado el 06 jun 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All f/hold alnd l/hold property with all fixtures thereon the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. (For further details see doc M55).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jun 1984Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0