LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00671321 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED?
Dirección de la sede social | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2016 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2017 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 135 Bishopsgate London EC2M 3UR a 280 Bishopsgate London EC2M 4RB el 18 jul 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian John Isaac como director el 01 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Holden como director el 01 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Adam Holden como director el 11 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Paul Gadsby como director el 11 may 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Edmund Lord como director el 27 feb 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Timothy John Clibbens como director el 27 feb 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP* el 23 sept 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Barnard como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Paul Gadsby como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Baldock como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | St. Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24-25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
ISAAC, Ian John | Director | EC2M 4RB London, 280 Bishopsgate England | England | British | Head Of Asset Finance Portfolio | 195554680001 | ||||||||
LORD, Peter Edmund | Director | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | Finance House Manager | 195549570001 | ||||||||
BROMLEY, Heidi Elizabeth | Secretario | 40 Hitchings Way RH2 8EW Reigate Surrey | British | 33605720002 | ||||||||||
CAMERON, Lindsey Helen | Secretario | The Terrace Glenlomond KY13 9HF Kinross Suite Gleann Cottage, 1 | Other | 132335590001 | ||||||||||
CUNNINGHAM, Angela Mary | Secretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
EVANS, Margaret Janet | Secretario | 17 Coniston Way RH2 0LN Reigate Surrey | British | 2289880001 | ||||||||||
RUSSELL, Christine Anne | Secretario | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 165379630001 | |||||||||||
STRANAGHAN, Patricia Ann | Secretario | Flat 1 25 Somers Road RH2 9DY Reigate Surrey | British | 39114460001 | ||||||||||
WHITTAKER, Carolyn Jean | Secretario | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
WRAITH CARTER, Gillian | Secretario | 8 Great Lime Kilns Southwater RH13 9JL Horsham West Sussex | British | 109333000001 | ||||||||||
ASHWORTH, George Smith-Salmond | Director | 2 Laurelsfield AL3 4BZ St Albans Hertfordshire | England | English | Banker | 152638710001 | ||||||||
BALDOCK, Alexander David | Director | Westbourne Park Road W11 1EP London 218 United Kingdom | United Kingdom | British | Bank Official | 132330380001 | ||||||||
BARNARD, Andrew David | Director | Bell Cottage Bell Road RH12 3QL Warnham Bell Cottage West Sussex England | England | British | Bank Official | 137736080001 | ||||||||
BEESTON, Alistair John | Director | Three Oaks Vauxhall Lane Southborough TN4 0XD Tunbridge Wells Kent | British | Banker | 10670790001 | |||||||||
CARTE, Brian Addison | Director | Fairfield Lodge Hardwick Close Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | United Kingdom | British | Banker | 145559220001 | ||||||||
CLEMETT, Graham Colin | Director | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 123744930001 | ||||||||
CLIBBENS, Nigel Timothy John | Director | 40a Pennington Road Southborough TN4 0SL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 49141230004 | ||||||||
FITCH, John Derek | Director | Douglas Cottage Coombe End KT2 7DQ Kingston Surrey | British | Deputy Chief Executive | 8461210001 | |||||||||
GADSBY, Andrew Paul | Director | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 England | England | British | Bank Official | 74834980002 | ||||||||
HIGGINS, Peter | Director | 2 Grange Close RH1 4LW Bletchingley Surrey | England | British | Finance House Manager | 107984310001 | ||||||||
HOLDEN, Adam | Director | Elmwood Avenue TW13 7QD Feltham Smith House Middlesex England | England | British | Bank Official | 185018800001 | ||||||||
JOHNSON, Jeffrey | Director | Hill House 28 Maldon Road Danbury CM3 4QH Chelmsford Essex | British | Accountant | 103077710001 | |||||||||
KAPUR, Neeraj | Director | The Old Granary Hillside Road GU10 3AJ Frensham Surrey | United Kingdom | British | Bank Official | 122158360001 | ||||||||
KNOWLES, Christopher George | Director | Whispering Well House Chander Hill Lane, Holymoorside S42 7HN Chesterfield Derbyshire | British | Bank Executive | 67501900002 | |||||||||
LYNAM, Paul Anthony | Director | 24 Warwick Road RG2 7AX Reading Berkshire | United Kingdom | Irish | Managing Director | 100755360001 | ||||||||
MABERLY, Michael Alan | Director | Endellion Money Row Green Holyport SL6 2NA Maidenhead Berkshire | British | Director | 1288990001 | |||||||||
MAPPLEBECK, John Richard | Director | 73 Manor Road South Hinchley Wood KT10 0QB Esher Surrey | England | British | Senior Executive | 76533440001 | ||||||||
MARROW, Paul | Director | The Shutters 2 Nightjar Close Ewshot GU10 5TQ Farnham Surrey | United Kingdom | British | Banker | 85771600001 | ||||||||
PEARCE, Nigel | Director | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | Banker | 63084840002 | ||||||||
POWELL, Martin Edward | Director | Monroe Station Road Hatfield Peverel CM3 2DS Chelmsford | United Kingdom | British | Director Risk & Regulation | 59795080001 | ||||||||
PRIESTMAN, Richard Mark | Director | 31 Hove Park Villas BN3 6HH Hove Sussex | England | British | Chartered Accountant | 74412220002 | ||||||||
PURDY, John Douglas | Director | Kendals Little Heath Lane, Potten End HP4 2RY Berkhamsted Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 68943220001 | |||||||||
ROOME, Harry Mccrea | Director | The Duchies Mill Lane, Pirbright GU24 0BT Woking Surrey | England | British | Acc/Banker | 64898180001 | ||||||||
STUART, John David | Director | 69 Howards Thicket SL9 7NU Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Director | 76974710001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lombard North Central Plc | 06 abr 2016 | EC2M 4RB London 280 Bishopsgate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene LOMBARD NORTH CENTRAL WHEELEASE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of assignment | Creado el 31 may 1984 Entregado el 19 jun 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee chemical bank as agent for the banks under the terms of the boring counter indemnity dated 31ST may 1984 | |
Breve descripción All of the company's right, title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boring company to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed or assignment | Creado el 31 may 1984 Entregado el 19 jun 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee chemical bank as agent for the banks under the terms of the boring counter indemnity dated 31ST may 1984 | |
Breve descripción All of the company's right, title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boring company to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0