PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED

PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00675502
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Findel House
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 mar 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 20 dic 2021

    • Capital: GBP 0.50
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premuim account 17/12/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 17 dic 2021

    • Capital: GBP 31,764.5
    3 páginasSH01

    Cancelación total de la carga 006755020009

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 006755020010

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 03 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Stuart Murdoch Caldwell como director el 16 abr 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Ashcroft como secretario el 16 abr 2021

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Mark Ashcroft como director el 16 abr 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Mark Whittaker como director el 16 abr 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Martin David Jones como director el 16 abr 2021

    2 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    19 páginasMA

    Nombramiento de Mr Chris David Mahady como director el 16 abr 2021

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE United Kingdom a Findel House Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4HR el 14 may 2021

    1 páginasAD01

    Registro de la carga 006755020010, creada el 16 abr 2021

    57 páginasMR01

    Registro de la carga 006755020009, creada el 16 abr 2021

    44 páginasMR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 mar 2020

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Philip Binns Maudsley como director el 26 mar 2021

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JONES, Martin David
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish202929240001
    MAHADY, Chris David
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish283179270001
    WHITTAKER, Mark
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish90423740002
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165369070001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Secretario
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    British14333000007
    HORSFIELD, Ian James
    Griffin House Zion Road
    SP11 7EN Andover
    Hampshire
    Secretario
    Griffin House Zion Road
    SP11 7EN Andover
    Hampshire
    British47448200001
    JARVIS, Ernest Arthur
    Forest Edge Straight Mile
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    Secretario
    Forest Edge Straight Mile
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    British12774730001
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113691350001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Director
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish14333000007
    CALDWELL, Stuart Murdoch
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish229000880001
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish143093130001
    DUTTON, David Brian
    Marsden Old Vicarage
    20 Station Road
    HD7 6DG Marsden
    West Yorkshire
    Director
    Marsden Old Vicarage
    20 Station Road
    HD7 6DG Marsden
    West Yorkshire
    United KingdomBritish153319990001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Director
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    JARVIS, Ernest Arthur
    49 Newton Lane
    SO51 8GX Romsey
    Hampshire
    Director
    49 Newton Lane
    SO51 8GX Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish12774730002
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    Director
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritish75327660001
    KOWALSKI, Timothy John
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Director
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    UkBritish153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Director
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish15967010001
    SIDDLE, Roger William John
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Director
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    EnglandBritish46903210001
    TACEY, Charles Arthur
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    Director
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    British12774740001
    TACEY, John Walter Frank
    Nakuru Red Post Lane
    Weyhill
    SP11 0PY Andover
    Hampshire
    Director
    Nakuru Red Post Lane
    Weyhill
    SP11 0PY Andover
    Hampshire
    British2191970001
    TACEY, Jon
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    Director
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    EnglandBritish62240540001
    TACEY, Noel Christopher
    Bramble End
    Burlescombe
    EX16 7JW Tiverton
    Devon
    Director
    Bramble End
    Burlescombe
    EX16 7JW Tiverton
    Devon
    EnglandBritish12774720003
    TACEY, Paul John Thornton
    7 Queen Alexandra Road
    SP2 9LL Salisbury
    Wiltshire
    Director
    7 Queen Alexandra Road
    SP2 9LL Salisbury
    Wiltshire
    British55132040001
    VAUGHAN, Gerald David
    Little Talboys
    Main Street Keevil
    BA14 6LM Trowbridge
    Wiltshire
    Director
    Little Talboys
    Main Street Keevil
    BA14 6LM Trowbridge
    Wiltshire
    British57879940002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Findel Education Limited
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroUnited Kingdom Companies House
    Número de registro01135827
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 16 abr 2021
    Entregado el 22 abr 2021
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Studio Retail Group PLC (As Lender)
    Transacciones
    • 22 abr 2021Registro de una carga (MR01)
    • 15 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 16 abr 2021
    Entregado el 19 abr 2021
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Endless LLP
    Transacciones
    • 19 abr 2021Registro de una carga (MR01)
    • 15 dic 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 21 ene 2015
    Entregado el 27 ene 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ene 2015Registro de una carga (MR01)
    • 05 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creado el 28 jul 2010
    Entregado el 06 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First legal mortgage all of the 860 ordinary shares in protus plastics limited, 4543 ordinary and 2000 preference shares in philip & tacey limited.. £2,532,000 inter-group loan agreement.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 05 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession to the security agreement
    Creado el 16 jul 2010
    Entregado el 29 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 29 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 05 ene 2016Satisfacción parcial de una carga (MR04)
    • 05 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 14 sept 2000
    Entregado el 28 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1 north way walworth industrial estate andover. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 nov 1999
    Entregado el 17 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 17 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 07 mar 1985
    Entregado el 14 mar 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H factory pottington industrial estate, barnstaple, devon.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1985Registro de una carga
    • 27 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 07 mar 1985
    Entregado el 14 mar 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H warehouse pottington industrial estate, barnstaple, devon.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1985Registro de una carga
    • 27 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1979
    Entregado el 19 abr 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 47922.03
    Breve descripción
    (1) 1.08 acres of land on the pottington industrial estate, barnstaple, devon (2) 0.14 acres of land on the pottington industrial estate, barnstaple, devon.
    Personas con derecho
    • Devon County Council
    Transacciones
    • 19 abr 1979Registro de una carga
    • 06 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0