PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00675502 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Findel House Gregory Street SK14 4HR Hyde Cheshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 27 mar 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 20 dic 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 17 dic 2021
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 006755020009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 006755020010 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart Murdoch Caldwell como director el 16 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Ashcroft como secretario el 16 abr 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Ashcroft como director el 16 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Whittaker como director el 16 abr 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Martin David Jones como director el 16 abr 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 19 páginas | MA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Chris David Mahady como director el 16 abr 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE United Kingdom a Findel House Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4HR el 14 may 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 006755020010, creada el 16 abr 2021 | 57 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 006755020009, creada el 16 abr 2021 | 44 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 mar 2020 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Binns Maudsley como director el 26 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Martin David | Director | Gregory Street SK14 4HR Hyde Findel House Cheshire United Kingdom | England | British | 202929240001 | |||||
| MAHADY, Chris David | Director | Gregory Street SK14 4HR Hyde Findel House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 283179270001 | |||||
| WHITTAKER, Mark | Director | Gregory Street SK14 4HR Hyde Findel House Cheshire United Kingdom | England | British | 90423740002 | |||||
| ASHCROFT, Mark | Secretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire United Kingdom | 165369070001 | |||||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Secretario | 2 Gregory Street SK14 4HR Hyde Cheshire England | British | 14333000007 | ||||||
| HORSFIELD, Ian James | Secretario | Griffin House Zion Road SP11 7EN Andover Hampshire | British | 47448200001 | ||||||
| JARVIS, Ernest Arthur | Secretario | Forest Edge Straight Mile Ampfield SO51 9BA Romsey Hampshire | British | 12774730001 | ||||||
| ASHCROFT, Mark | Director | Gregory Street SK14 4HR Hyde Findel House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 113691350001 | |||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Director | 2 Gregory Street SK14 4HR Hyde Cheshire England | United Kingdom | British | 14333000007 | |||||
| CALDWELL, Stuart Murdoch | Director | Gregory Street SK14 4HR Hyde Findel House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 229000880001 | |||||
| CHAPMAN, Keith | Director | Flasby BD23 3PX Skipton Flasby Hall North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 143093130001 | |||||
| DUTTON, David Brian | Director | Marsden Old Vicarage 20 Station Road HD7 6DG Marsden West Yorkshire | United Kingdom | British | 153319990001 | |||||
| HINTON, Christopher David | Director | Henry Street Church BB5 4EH Accrington Church Bridge House Lancashire | England | British | 68474940001 | |||||
| JARVIS, Ernest Arthur | Director | 49 Newton Lane SO51 8GX Romsey Hampshire | United Kingdom | British | 12774730002 | |||||
| JOLLY, Patrick Edmund | Director | Hill Top Farm Hill Top Lane Skipton Road, BB18 6JN Earby Lancashire | England | British | 75327660001 | |||||
| KOWALSKI, Timothy John | Director | 2 Gregory Street SK14 4HR Hyde Cheshire England | Uk | British | 153335190003 | |||||
| MAUDSLEY, Philip Binns | Director | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 15967010001 | |||||
| SIDDLE, Roger William John | Director | 2 Gregory Street SK14 4HR Hyde Cheshire England | England | British | 46903210001 | |||||
| TACEY, Charles Arthur | Director | Waylands Hurstbourne Tarrant SP11 0BD Andover Hampshire | British | 12774740001 | ||||||
| TACEY, John Walter Frank | Director | Nakuru Red Post Lane Weyhill SP11 0PY Andover Hampshire | British | 2191970001 | ||||||
| TACEY, Jon | Director | Waylands Hurstbourne Tarrant SP11 0BD Andover Hampshire | England | British | 62240540001 | |||||
| TACEY, Noel Christopher | Director | Bramble End Burlescombe EX16 7JW Tiverton Devon | England | British | 12774720003 | |||||
| TACEY, Paul John Thornton | Director | 7 Queen Alexandra Road SP2 9LL Salisbury Wiltshire | British | 55132040001 | ||||||
| VAUGHAN, Gerald David | Director | Little Talboys Main Street Keevil BA14 6LM Trowbridge Wiltshire | British | 57879940002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Findel Education Limited | 06 abr 2016 | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PHILOGRAPH PUBLICATIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 16 abr 2021 Entregado el 22 abr 2021 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 16 abr 2021 Entregado el 19 abr 2021 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 21 ene 2015 Entregado el 27 ene 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental security agreement | Creado el 28 jul 2010 Entregado el 06 ago 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First legal mortgage all of the 860 ordinary shares in protus plastics limited, 4543 ordinary and 2000 preference shares in philip & tacey limited.. £2,532,000 inter-group loan agreement. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession to the security agreement | Creado el 16 jul 2010 Entregado el 29 jul 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage deed | Creado el 14 sept 2000 Entregado el 28 sept 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 1 north way walworth industrial estate andover. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 16 nov 1999 Entregado el 17 nov 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 07 mar 1985 Entregado el 14 mar 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H factory pottington industrial estate, barnstaple, devon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 07 mar 1985 Entregado el 14 mar 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H warehouse pottington industrial estate, barnstaple, devon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 29 mar 1979 Entregado el 19 abr 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 47922.03 | |
Breve descripción (1) 1.08 acres of land on the pottington industrial estate, barnstaple, devon (2) 0.14 acres of land on the pottington industrial estate, barnstaple, devon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0