WYNDEHAM HUBBARD LIMITED

WYNDEHAM HUBBARD LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWYNDEHAM HUBBARD LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00685005
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?

    Dirección de la sede social
    18 Westside Centre London Road
    Stanway
    CO3 8PH Colchester
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    B.R.HUBBARD PRINTERS LIMITED01 mar 196101 mar 1961

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020

    3 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH England a 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH el 20 jul 2021

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2019

    3 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH England a 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH el 02 oct 2020

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Zoe Repman como secretario el 19 sept 2019

    1 páginasTM02

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2018

    2 páginasAA

    Cancelación total de la carga 11

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Bentalls Complex Colchester Road Heybridge Essex CM9 4NW a 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH el 24 ago 2016

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Mr Paul George Utting el 22 jun 2016

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ago 2015

    Estado de capital el 19 ago 2015

    • Capital: GBP 235,950
    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jul 2014

    Estado de capital el 18 jul 2014

    • Capital: GBP 235,950
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    UTTING, Paul George
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    Director
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector65550960005
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Secretario
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    BritishChartered Accountant15201600002
    HUBBARD, Barrie Weymouth
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    British2012700001
    REPMAN, Zoe
    Westside Centre
    London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    Secretario
    Westside Centre
    London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    Essex
    England
    147370870001
    UTTING, Paul George
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Secretario
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    British65550960004
    BEDSON, Bryan Stanley
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    Director
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director18576770001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Director
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant152718990001
    EDWARDS, Michael Ian
    42 Petworth Close
    CM77 7XS Great Notley
    Essex
    Director
    42 Petworth Close
    CM77 7XS Great Notley
    Essex
    BritishChartered Accountant115842570001
    FOX, Colin Charles
    18 Mount Crescent
    Broadmeadows
    DE55 3NS Alfreton
    Derbyshire
    Director
    18 Mount Crescent
    Broadmeadows
    DE55 3NS Alfreton
    Derbyshire
    BritishPrinter77114410001
    HERON, Edward Richard
    3 The Granaries
    Station Road
    CM9 4LQ Maldon
    Essex
    Director
    3 The Granaries
    Station Road
    CM9 4LQ Maldon
    Essex
    BritishPrinter4125100002
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Director
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant15201600002
    HUBBARD, Barrie Weymouth
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm
    Ridgeway
    S12 3XW Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishPrinter2012700001
    HUBBARD, John
    20 Morley Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5YQ Sheffield
    Director
    20 Morley Close
    Dronfield Woodhouse
    S18 5YQ Sheffield
    United KingdomBritishPrinter26988890001
    MYLES, Malcolm
    4 Longcroft Avenue
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PJ Dronfield Sheffield
    Director
    4 Longcroft Avenue
    Dronfield Woodhouse
    S18 8PJ Dronfield Sheffield
    BritishPrinter29348250003
    OWEN, Jonathan Spencer
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    Director
    42 Woodland Avenue
    BN3 6BL Hove
    East Sussex
    BritishChartered Accountant92040070002
    PAGE, Andrew Stephen
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    Director
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector86557080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wyndeham Press Group Limited
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    England
    06 abr 2016
    Westside Centre, London Road
    CO3 8PH Colchester
    22
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro933418
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene WYNDEHAM HUBBARD LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Full form debenture
    Creado el 05 dic 2008
    Entregado el 19 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Leumi Abl Limited
    Transacciones
    • 19 dic 2008Registro de un cargo (395)
    • 26 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 01 dic 2006
    Entregado el 08 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transacciones
    • 08 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattels mortgage
    Creado el 01 dic 2006
    Entregado el 08 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assigns by way of security the mortgaged chattels,the benefit of any obligations,guarantees and warranties undertaken or given,all maintenance or support agreements,all authorisations,the benefit of the insurance proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transacciones
    • 08 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 11 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession and restatement
    Creado el 07 jun 2006
    Entregado el 13 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Property being, the bentalls complex, colchester road, maldon, essex t/no EX443872. Castle press, 371, victoria street,grimsby t/no HS165423. Unit 11/12 grange industrial estate, grange road, southwick, west sussex t/no WSX142782. For details of further property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Landsbanki Islands Hf (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) the Security Trustee
    Transacciones
    • 13 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 jul 2005
    Entregado el 02 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 24 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assignment of komori lithrone L44011 four colour offset printing press serial number 1063 ("the equipment") including any part or parts thereto and all additions alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 12 ago 1993
    Entregado el 16 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-callywhite lane dronfield in the county of derby and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 jul 1993
    Entregado el 30 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 21 sept 1982
    Entregado el 30 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to williams & glyn's bank PLC supplemental to a debenture dated 15 jan. 1965.
    Breve descripción
    All book debts & other debts present & future.
    Personas con derecho
    • Mosley Street Nominees Limited.
    Transacciones
    • 30 sept 1982Registro de una carga
    • 16 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 jun 1980
    Entregado el 07 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold land and buildings fronting callywhite lane, dronfield, north east derbyshire together with all fixtures whatsoever now or at any time there after affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. all fixed and moveable plant, machinery and fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transacciones
    • 07 jul 1980Registro de una carga
    • 16 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 nov 1976
    Entregado el 22 nov 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD.
    Breve descripción
    1. f/h piece or parcel of land situate fronting to callywhite lane dronfield derbyshire containing 943 sq yds approx: excepting therefrom 200 sq. Yards. 2. and further pieces of land situate nr to gallywhite lane aforesaid. Together with all fixtures whatsoever, defined by sect 5 of the bills of sale act 1878. all fixed & movable plant machinery & fixtures, implements & utensils from time to time therein or thereon.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank LTD.
    Transacciones
    • 22 nov 1976Registro de una carga
    • 16 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 15 ene 1965
    Entregado el 20 ene 1965
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD.
    Breve descripción
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital with all buildings & fixtures (see doc. 20).
    Personas con derecho
    • Mosley Street Nominees LTD.
    Transacciones
    • 20 ene 1965Registro de una carga
    • 15 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0