WYNDEHAM HUBBARD LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | WYNDEHAM HUBBARD LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00685005 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Dirección de la sede social | 18 Westside Centre London Road Stanway CO3 8PH Colchester England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
B.R.HUBBARD PRINTERS LIMITED | 01 mar 1961 | 01 mar 1961 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH England a 18 Westside Centre London Road Stanway Colchester CO3 8PH el 20 jul 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2019 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH England a 18 London Road Stanway Colchester CO3 8PH el 02 oct 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Zoe Repman como secretario el 19 sept 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 11 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Bentalls Complex Colchester Road Heybridge Essex CM9 4NW a 22 Westside Centre London Road Colchester Essex CO3 8PH el 24 ago 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul George Utting el 22 jun 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTING, Paul George | Director | Westside Centre, London Road CO3 8PH Colchester 22 Essex England | England | British | Director | 65550960005 | ||||
HOLLEBONE, Paul Stephen | Secretario | Old Orchard Dog Lane BN44 3GE Steyning West Sussex | British | Chartered Accountant | 15201600002 | |||||
HUBBARD, Barrie Weymouth | Secretario | Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm Ridgeway S12 3XW Sheffield South Yorkshire | British | 2012700001 | ||||||
REPMAN, Zoe | Secretario | Westside Centre London Road CO3 8PH Colchester 22 Essex England | 147370870001 | |||||||
UTTING, Paul George | Secretario | 2 Walpole Gardens Strawberry Hill TW2 5SJ Twickenham | British | 65550960004 | ||||||
BEDSON, Bryan Stanley | Director | The Old Rectory Patching BN13 3XF Arundel West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 18576770001 | ||||
COPPOCK, Lawrence Patrick | Director | The Close Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | England | United Kingdom | Chartered Accountant | 152718990001 | ||||
EDWARDS, Michael Ian | Director | 42 Petworth Close CM77 7XS Great Notley Essex | British | Chartered Accountant | 115842570001 | |||||
FOX, Colin Charles | Director | 18 Mount Crescent Broadmeadows DE55 3NS Alfreton Derbyshire | British | Printer | 77114410001 | |||||
HERON, Edward Richard | Director | 3 The Granaries Station Road CM9 4LQ Maldon Essex | British | Printer | 4125100002 | |||||
HOLLEBONE, Paul Stephen | Director | Old Orchard Dog Lane BN44 3GE Steyning West Sussex | England | British | Chartered Accountant | 15201600002 | ||||
HUBBARD, Barrie Weymouth | Director | Sickle Cottage Ridgeway Moor Farm Ridgeway S12 3XW Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Printer | 2012700001 | ||||
HUBBARD, John | Director | 20 Morley Close Dronfield Woodhouse S18 5YQ Sheffield | United Kingdom | British | Printer | 26988890001 | ||||
MYLES, Malcolm | Director | 4 Longcroft Avenue Dronfield Woodhouse S18 8PJ Dronfield Sheffield | British | Printer | 29348250003 | |||||
OWEN, Jonathan Spencer | Director | 42 Woodland Avenue BN3 6BL Hove East Sussex | British | Chartered Accountant | 92040070002 | |||||
PAGE, Andrew Stephen | Director | 29 Russell Avenue MK40 3TD Bedford Bedfordshire | England | British | Director | 86557080001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WYNDEHAM HUBBARD LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyndeham Press Group Limited | 06 abr 2016 | Westside Centre, London Road CO3 8PH Colchester 22 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene WYNDEHAM HUBBARD LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Full form debenture | Creado el 05 dic 2008 Entregado el 19 dic 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 01 dic 2006 Entregado el 08 dic 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Chattels mortgage | Creado el 01 dic 2006 Entregado el 08 dic 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Assigns by way of security the mortgaged chattels,the benefit of any obligations,guarantees and warranties undertaken or given,all maintenance or support agreements,all authorisations,the benefit of the insurance proceeds. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of accession and restatement | Creado el 07 jun 2006 Entregado el 13 jun 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Property being, the bentalls complex, colchester road, maldon, essex t/no EX443872. Castle press, 371, victoria street,grimsby t/no HS165423. Unit 11/12 grange industrial estate, grange road, southwick, west sussex t/no WSX142782. For details of further property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 20 jul 2005 Entregado el 02 ago 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Chattel mortgage | Creado el 20 nov 1995 Entregado el 24 nov 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Assignment of komori lithrone L44011 four colour offset printing press serial number 1063 ("the equipment") including any part or parts thereto and all additions alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 12 ago 1993 Entregado el 16 ago 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H-callywhite lane dronfield in the county of derby and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 23 jul 1993 Entregado el 30 jul 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed | Creado el 21 sept 1982 Entregado el 30 sept 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to williams & glyn's bank PLC supplemental to a debenture dated 15 jan. 1965. | |
Breve descripción All book debts & other debts present & future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 25 jun 1980 Entregado el 07 jul 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold land and buildings fronting callywhite lane, dronfield, north east derbyshire together with all fixtures whatsoever now or at any time there after affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. all fixed and moveable plant, machinery and fixtures implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 11 nov 1976 Entregado el 22 nov 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD. | |
Breve descripción 1. f/h piece or parcel of land situate fronting to callywhite lane dronfield derbyshire containing 943 sq yds approx: excepting therefrom 200 sq. Yards. 2. and further pieces of land situate nr to gallywhite lane aforesaid. Together with all fixtures whatsoever, defined by sect 5 of the bills of sale act 1878. all fixed & movable plant machinery & fixtures, implements & utensils from time to time therein or thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 15 ene 1965 Entregado el 20 ene 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due etc. to williams beacon's bank LTD. | |
Breve descripción Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital with all buildings & fixtures (see doc. 20). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0