DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED

DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDOUGLAS EQUIPMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00697744
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    • fabricación de aeronaves y naves espaciales y maquinaria relacionada (30300) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ML DOUGLAS EQUIPMENT LTD22 jul 198822 jul 1988
    F.L. DOUGLAS (EQUIPMENT) LIMITED10 jul 196110 jul 1961

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 02 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 ene 2015

    Estado de capital el 07 ene 2015

    • Capital: GBP 16,162,000
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 ene 2014

    Estado de capital el 03 ene 2014

    • Capital: GBP 16,162,000
    SH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2013

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Weil como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Matthew Johnson como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    20 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Nombramiento de Mr Matthew Philip Johnson como director

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de * Douglas House, Village Road Cheltenham Gloucestershire GL51 0AB* el 23 may 2011

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Lee Brewis como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr John Richard Duffy como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Robert Stephen Towill como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 02 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director David Frederick Weil el 02 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    19 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TOWILL, Robert Stephen
    Bumblebees
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario
    Bumblebees
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    BritishAccountant86728020001
    DUFFY, John Richard
    c/o 35th Floor
    3 Sheung Yuet Road
    Kowloon
    Enterprise Square Two
    Hong Kong
    Hong Kong
    Director
    c/o 35th Floor
    3 Sheung Yuet Road
    Kowloon
    Enterprise Square Two
    Hong Kong
    Hong Kong
    Hong KongBritishDirector149894980001
    TOWILL, Robert Stephen
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    Director
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant86728020001
    BREWIS, Carolyn Julie
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSecretary84647400002
    COLEMAN, Christopher John
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant91487190001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Secretario
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    BritishAccountant36711070001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Secretario
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    BritishAccountant36711070001
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    British2641580001
    SIMS, Robin Edward
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    Secretario
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    British52343580001
    WALLIS, Robert Charles Hedley
    1 Glebe Field
    Almondsbury
    BS32 4DL Bristol
    Glocestershire
    Secretario
    1 Glebe Field
    Almondsbury
    BS32 4DL Bristol
    Glocestershire
    British56610660001
    ATKINSON, Roger Scott
    The Flinthouse
    Pound Lane
    WR6 6EE Clifton On Teme
    Worcester
    Director
    The Flinthouse
    Pound Lane
    WR6 6EE Clifton On Teme
    Worcester
    United KingdomBritishCompany Director82851270001
    BENJAMIN, John
    Virginia Cottage
    102 Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Virginia Cottage
    102 Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director75927710002
    BREWIS, Carolyn Julie
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSecretary84647400002
    BREWIS, Lee Alexander
    The Bothy Rushley Lane
    Winchcombe
    GL54 5JE Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    The Bothy Rushley Lane
    Winchcombe
    GL54 5JE Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAustralianManaging Director84653460003
    BROWN, William Francis
    7 Oaken Drive
    B91 1RJ Solihull
    West Midlands
    Director
    7 Oaken Drive
    B91 1RJ Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director3716160001
    BRYANT, Michael John
    Oakwood Brake Lane
    West Hagley
    DY8 2XW Stourbridge
    West Midlands
    Director
    Oakwood Brake Lane
    West Hagley
    DY8 2XW Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector61720130001
    BRYSON, John Macdonald
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    Director
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    BritishGroup Finance Director10076550001
    BURTON, Stephen Leslie
    Lynton House
    Queens Drive,
    CV35 7DA Rowington
    Warwick
    Director
    Lynton House
    Queens Drive,
    CV35 7DA Rowington
    Warwick
    BritishDirector71989770001
    CALLOW, John William
    1 Fairhurst Drive
    CV32 6HX Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    1 Fairhurst Drive
    CV32 6HX Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector51889810001
    COLEMAN, Christopher John
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant91487190001
    DOANE, Michael John
    24 Timperley Way
    Upper Hatherley
    GL51 5RH Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    24 Timperley Way
    Upper Hatherley
    GL51 5RH Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director22589290001
    DUNN, John Michael
    17 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    Director
    17 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director3716190001
    FLEMING, John
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    Director
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    BritishCompany Director107749800001
    GARDINER, Anthony Martin
    7 Churchill Gate
    OX20 1QW Woodstock
    Oxfordshire
    Director
    7 Churchill Gate
    OX20 1QW Woodstock
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant/Finance Director39207890001
    GEARY, Patrick Brendan
    3 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2SN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    3 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2SN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector80957730001
    HAUGHTON, Adrian Paul
    Barn Cottage Grimers Farm
    Pendock Road
    GL19 3LG Redmarley
    Gloucestershire
    Director
    Barn Cottage Grimers Farm
    Pendock Road
    GL19 3LG Redmarley
    Gloucestershire
    BritishCompany Director50089840001
    HENFREY, Anthony William, Dr
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    Director
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    EnglandBritishCompany Director42207200001
    HICKS, Frank
    The Old Dairy Park Lane
    Swalcliffe
    OX15 5EU Banbury
    Oxfordshire
    Director
    The Old Dairy Park Lane
    Swalcliffe
    OX15 5EU Banbury
    Oxfordshire
    BritishCompany Director23572310001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Director
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector36711070001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Director
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomBritishAccountant36711070001
    JOHNSON, Matthew Philip
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    Director
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    Hong KongBritishAccountant160346740001
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSolicitor2641580001
    PAUL, Peter Michael, Director
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    Director
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    BritishCompany Director7677600002
    PICKERING, Ian
    Avenue House The Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8HH Milton Keynes
    Bedfordshire
    Director
    Avenue House The Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8HH Milton Keynes
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector3014270002
    PLANT, Nigel Andrew
    2 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Director
    2 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishEngineering Director100058440001

    ¿Tiene DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 13 dic 2006
    Entregado el 15 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Douglas house village road cheltenham glos t/no GR146878. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 15 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 08 nov 2006
    Entregado el 15 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 11 jun 2003
    Entregado el 12 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings on the west side of village road arle t/n GR146878. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 abr 2003
    Entregado el 29 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 28 jul 1999
    Entregado el 10 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Breve descripción
    The freehold building 150 langar 11 industrial estate harby road langar rushcliff nottinghamshire title number NT210023 and land and buildings on the west side of village road arle cheltenham gloucestershire title number GR146878. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Agent and Trustee for the Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 10 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creado el 08 jun 1993
    Entregado el 15 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 07/08/92
    Breve descripción
    All that l/h property being premises at colndale road poyle middlesex.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 07 ago 1992
    Entregado el 17 ago 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 ago 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 21 sept 1983
    Entregado el 06 oct 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or F.L. douglas holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 1983Registro de una carga
    • 05 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0