UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION
Visión general
| Nombre de la empresa | UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 00701484 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
| Dirección de la sede social | Henry St Sheffield S3 7EQ |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SPRING RESEARCH AND MANUFACTURERS' ASSOCIATION (THE) | 23 ago 1961 | 23 ago 1961 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaraci ón de confirmación cerrada hasta | 07 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Christian Oliver el 18 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Luke James Orton como director el 18 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Christian Oliver como director el 18 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr James Roderick John Whitehead como director el 18 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Comptes modifiés d'exonération totale établis au 31 dic 2024 | 4 páginas | AAMD | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Patrick Mcsheehy como director el 18 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Nicholas Desmond Goss como director el 18 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 5 páginas | AA | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Matthew James Rawnsley como director el 11 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYD, Steven Martin | Director | 39 Pepper Street Inkberrow WR7 4EW Worcester | United Kingdom | British | 122791010001 | |||||
| CLARK, Bruce William | Director | Henry St Sheffield S3 7EQ | England | British | 80465660001 | |||||
| CLIFFORD, John Keith | Director | Northwick Road WR11 3AN Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | England | British | 132701920001 | |||||
| DRIVER, Christian Oliver | Director | Henry St Sheffield S3 7EQ | England | British | 341637180002 | |||||
| HUGHES, Max Ivo Arthur | Director | Chaffeymoor House Bourton SP8 5BY Gillingham Dorset | United Kingdom | English | 15710410001 | |||||
| LAIGHT, Rodney James | Director | Henry St Sheffield S3 7EQ | England | British | 5246880004 | |||||
| ORTON, Luke James | Director | Henry St Sheffield S3 7EQ | England | British | 341637320001 | |||||
| PARKINSON, Timothy Michael | Director | 11 Linton Avenue Cobby Dale Park Silsden BD20 9LE Keighley West Yorkshire | England | British | 73403100001 | |||||
| TURNER, Andrew Philip | Director | 11 Riverdale Gardens TW1 2BX East Twickenham Middlesex | England | British | 98605430002 | |||||
| WHITEHEAD, James Roderick John | Director | Henry St Sheffield S3 7EQ | England | British | 338218170001 | |||||
| WILLIAMS, Stephen Mark | Director | 16 Lord Street FY8 2DF Lytham St Annes Lancashire | England | English | 79905370001 | |||||
| HOOPER, Arthur | Secretario | 40 Yewdale Road HG2 8NE Harrogate | British | 3114630003 | ||||||
| WATKINSON, Andrew Christopher | Secretario | 9 Green Close Renishaw S21 3WS Sheffield Yorkshire | British | 106017560002 | ||||||
| BANKS FEAR, Pauline Isabel | Director | 11 Orford Close BH23 2TF Christchurch Dorset | British | 52674130001 | ||||||
| BECK, Richard Alan | Director | 296 Ralph Road Shirley B90 3PE Solihull West Midlands | British | 45950020001 | ||||||
| BEVANS, Andrew Roland | Director | 5 King Street Seagrave LE12 7LY Loughborough Leicestershire | British | 21003900002 | ||||||
| BRIERLEY, Anthony John | Director | 14 Bell Lane The Delves WS5 4ES Walsall West Midlands | United Kingdom | British | 15301390001 | |||||
| DASHPER, John Keith | Director | Todwick Grange Todwick S26 1JQ Nr. Sheffield The Grange South Yorkshire England | United Kingdom | British | 136128860001 | |||||
| DOWNEND, Keith | Director | 6 Laburnum Close S80 3BY Worksop Nottinghamshire | British | 12280280001 | ||||||
| EDWARDS, Bryan | Director | Rockingstone Cottages The Common CF37 4AW Pontypridd Mid Glamorgan | Wales | British | 180605860001 | |||||
| FISHER, Ian Albert, Dr | Director | Whytecote Church Street S42 7JQ Youlgreave | British | 30138680002 | ||||||
| GIBBS, Michael Ralph | Director | Lane End St. Gluvias TR10 9AX Penryn The Firs Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | 132701930002 | |||||
| GOSS, Edward Thomas | Director | Knoll House Bury Road Chingford E4 7QL London | British | 10065350001 | ||||||
| GOSS, Nicholas Desmond | Director | Burgates The Street Little Dunmow CM6 3HT Dunmow Essex | United Kingdom | British | 10065360001 | |||||
| HAGUE, James | Director | 7 Tempest Avenue Darfield S73 9BJ Barnsley South Yorkshire | British | 13964230001 | ||||||
| HARRIS, Bryan Gordon Jean | Director | Fern Acre Fern Lane SL7 3SD Little Marlow Buckinghamshire | British | 81478070001 | ||||||
| HARRIS, Philip Jean Gordon | Director | Autumn Cottage Trees Road, Hughenden Valley HP14 4PN High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 70950220002 | |||||
| HOOPER, Arthur | Director | 40 Yewdale Road HG2 8NE Harrogate | British | 3114630003 | ||||||
| JONES, Colin | Director | Henry St Sheffield S3 7EQ | Wales | British | 180967490001 | |||||
| JONES, Trevor Stanley | Director | 15 De Moram Grove B92 0PZ Solihull West Midlands | British | 65497700001 | ||||||
| KELLY, Donald Joseph | Director | 8 Pelham Crescent NG7 1AW Nottingham | British | 36714420005 | ||||||
| KING, Maxwell Stephen | Director | 24 Rowan Road Shoal Hill WS11 1JJ Cannock Staffordshire | England | British | 74335150001 | |||||
| KNIGHT, Alfred William John | Director | Little Acre 9 Main Street Houghton On The Hill LE7 9GE Leicester Leicestershire | British | 15710420001 | ||||||
| KORZILIUS, Peter | Director | 1 Miz Maze Liegh DT9 6JJ Sherborne Dorset | Dutch | 15329140002 | ||||||
| LONG, Gerald | Director | Gwdj Hw Cottage Trerhyngyll CF71 7TH Cowbridge South Glamorgan | British | 31695310002 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para UK SPRING MANUFACTURERS' ASSOCIATION?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 07 jul 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0