VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED

VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00708992
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    21-23 Station Road
    SL9 8ES Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED08 jul 199808 jul 1998
    SPARE IPG 6 LIMITED05 jul 199405 jul 1994
    VICTOR BEATTIE HYDRAULICS LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    K. & B. BEATTIE (ENGINEERS) LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    BEATTIE & SIMM (ENGINEERS) LIMITED24 nov 196124 nov 1961

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Faraday House Sir William Siemens Square Frimley, Camberley Surrey GU16 8QD el 08 oct 2010

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 sept 2010

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 18 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital31 mar 2010

    Estado de capital el 31 mar 2010

    • Capital: GBP 1,146,209
    SH01

    Cambio de datos del secretario Mr Gerard Thomas Gent el 09 mar 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Ronald Smith el 02 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Gary Samuel Henderson Weir el 02 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    1 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Comptes modifiés établis au 30 sept 2008

    13 páginasAAMD

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2008

    12 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    9 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2007

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    2 páginas88(2)

    legacy

    2 páginas123

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de aumento del capital social autorizado

    RES04
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GENT, Gerard Thomas
    Station Road
    SL9 8ES Gerrards Cross
    21-23
    Buckinghamshire
    Secretario
    Station Road
    SL9 8ES Gerrards Cross
    21-23
    Buckinghamshire
    British51697750003
    SMITH, Ronald
    Station Road
    SL9 8ES Gerrards Cross
    21-23
    Buckinghamshire
    Director
    Station Road
    SL9 8ES Gerrards Cross
    21-23
    Buckinghamshire
    EnglandBritish109600790001
    WEIR, Gary Samuel Henderson
    Station Road
    SL9 8ES Gerrards Cross
    21-23
    Buckinghamshire
    Director
    Station Road
    SL9 8ES Gerrards Cross
    21-23
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74899150003
    ASHFIELD, John Richard
    4 Peckham Gardens
    Mackworth
    DE22 4FY Derby
    Secretario
    4 Peckham Gardens
    Mackworth
    DE22 4FY Derby
    British23703150001
    BEELEY, David John
    7 Lyndhurst Crescent
    NE9 6BA Gateshead
    Tyne & Wear
    Secretario
    7 Lyndhurst Crescent
    NE9 6BA Gateshead
    Tyne & Wear
    British164596910001
    GOMA, Delrose Joy
    8 Oakside Way
    Oakwood
    DE21 2UH Derby
    Derbyshire
    Secretario
    8 Oakside Way
    Oakwood
    DE21 2UH Derby
    Derbyshire
    British58167220001
    GRAHAM, Christopher
    Glenluce
    Birtley Chester Le Street
    DH3 2HY Durham
    66
    England
    United Kingdom
    Secretario
    Glenluce
    Birtley Chester Le Street
    DH3 2HY Durham
    66
    England
    United Kingdom
    British61088970002
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    Secretario
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    British39878290001
    MAUGHAN, Stephen William
    The Bungalow
    Westoe Village
    NE33 3EQ South Shields
    Tyne & Wear
    Secretario
    The Bungalow
    Westoe Village
    NE33 3EQ South Shields
    Tyne & Wear
    British55622330002
    MCGARGLE, Deborah Tracy
    12 Shellbark
    Biddick Woods
    DH4 7TD Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    12 Shellbark
    Biddick Woods
    DH4 7TD Washington
    Tyne & Wear
    British113674630001
    MCGARGLE, Deborah Tracy
    12 Shellbark
    Biddick Woods
    DH4 7TD Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    12 Shellbark
    Biddick Woods
    DH4 7TD Washington
    Tyne & Wear
    British113674630001
    SELLAR, Nigel Anthony
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    Secretario
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    British36687590001
    SELLAR, Nigel Anthony
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    Secretario
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    British36687590001
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Secretario corporativo
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    ALLAN, Gerard
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    Director
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    British44566730001
    ASHFIELD, John Richard
    4 Peckham Gardens
    Mackworth
    DE22 4FY Derby
    Director
    4 Peckham Gardens
    Mackworth
    DE22 4FY Derby
    British23703150001
    BEELEY, David John
    7 Lyndhurst Crescent
    NE9 6BA Gateshead
    Tyne & Wear
    Director
    7 Lyndhurst Crescent
    NE9 6BA Gateshead
    Tyne & Wear
    EnglandBritish164596910001
    CARLING, Robert
    1 Southlands
    Parkhill
    DH6 4LQ Coxhoe
    Durham
    Director
    1 Southlands
    Parkhill
    DH6 4LQ Coxhoe
    Durham
    EnglandBritish81733780001
    CONE, Harry Douglas
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Director
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    British796210001
    JONES, William Stanley
    19 Birney Edge
    Darras Hall
    DE20 9JJ Newcastle
    England
    Director
    19 Birney Edge
    Darras Hall
    DE20 9JJ Newcastle
    England
    British61089140001
    MAUGHAN, Stephen William
    The Bungalow
    Westoe Village
    NE33 3EQ South Shields
    Tyne & Wear
    Director
    The Bungalow
    Westoe Village
    NE33 3EQ South Shields
    Tyne & Wear
    British55622330002
    MOONEY, Phillip Wayne
    Austral Place
    Wideopen
    NE13 7HH Newcastle Upon Tyne
    44
    Tyne & Wear
    Director
    Austral Place
    Wideopen
    NE13 7HH Newcastle Upon Tyne
    44
    Tyne & Wear
    British76013080001
    OVERSTALL, Charles Andrew
    Moorside Cottage
    Hollinsclough
    SK17 0RF Buxton
    Derbyshire
    Director
    Moorside Cottage
    Hollinsclough
    SK17 0RF Buxton
    Derbyshire
    British53604540002
    SELDEN, Georg, Mag
    Mauerbachstr 5418
    Vienna
    Austria
    1140
    Director
    Mauerbachstr 5418
    Vienna
    Austria
    1140
    Austrian61137210001
    SELLAR, Nigel Anthony
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    Director
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    British36687590001
    SELLAR, Nigel Anthony
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    Director
    Low Leazes
    Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Northumberland
    British36687590001
    SNAITH, Richard
    22 Churchburn Drive
    Loansdene
    NE61 2BZ Morpeth
    Northumberland
    Director
    22 Churchburn Drive
    Loansdene
    NE61 2BZ Morpeth
    Northumberland
    British75973200001
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Director
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    WEST, Alan Edward
    163 Burley Lane
    Quarndon
    DE6 4JS Derby
    Derbyshire
    Director
    163 Burley Lane
    Quarndon
    DE6 4JS Derby
    Derbyshire
    British1661580001
    WILSON, David Richard
    3 Fencer Court
    NE3 2DP Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    Director
    3 Fencer Court
    NE3 2DP Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish210484430001

    ¿Tiene VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 mar 1980
    Entregado el 31 mar 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1980Registro de una carga
    • 02 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1976
    Entregado el 14 jun 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,720
    Breve descripción
    Hillman hunter motor car 216P, hillman hunter deluxe estate HC6217P, hillman hunter deluxe estate MC6 218P plus accessories.
    Personas con derecho
    • First National Bank of Chicago
    Transacciones
    • 14 jun 1976Registro de una carga
    • 24 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 17 mar 1975
    Entregado el 04 abr 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £90,000
    Breve descripción
    Four wickman multi spindle automatic machine tools.
    Personas con derecho
    • First Nationa Bank of Chicago
    Transacciones
    • 04 abr 1975Registro de una carga
    • 24 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene VA TECH REYROLLE (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 jul 2011Fecha de disolución
    29 sept 2010Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Helen Timothe Phillips
    21-23 Station Road
    Gerrards Cross
    SL9 8ES Bucks
    Profesional
    21-23 Station Road
    Gerrards Cross
    SL9 8ES Bucks

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0