RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00712215 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tor Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Berkshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RANK HOLIDAYS HOLDINGS LIMITED | 10 jun 1996 | 10 jun 1996 |
| RANK HOTELS (HOLDINGS) LIMITED | 20 may 1988 | 20 may 1988 |
| RANK HOTELS LIMITED | 04 ene 1962 | 04 ene 1962 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Christopher Pizey como director el 18 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Clive Adrian Roynon Jennings como director el 17 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Patrick O'reilly como director el 07 may 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Henry Benedict Birch como director el 07 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Frances Bingham como secretario el 01 may 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Notification de Rank (U.K.) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 jun 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Rank Leisure Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 jun 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cambio de datos del director Henry Benedict Birch el 12 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Statesman House Stafferton Way Maidenhead Berkshire SL6 1AY a Tor Saint-Cloud Way Maidenhead Berkshire SL6 8BN el 12 jun 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Clive Adrian Roynon Jennings el 04 jun 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Burke como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Henry Benedict Birch como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'REILLY, John Patrick | Director | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | England | British | 246366720001 | |||||
| PIZEY, James Christopher | Director | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | England | British | 249867130001 | |||||
| ADAMS, Charlotte | Secretario | 10 Park Way HA4 8NY Ruislip Middlesex | British | 52017000001 | ||||||
| BINGHAM, Frances | Secretario | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | Other | 130557520001 | ||||||
| COLES, Pamela Mary | Secretario | 36 London End HP9 2JH Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980002 | ||||||
| DE MIGUEL, Fiona Margaret | Secretario | 10 Lime Tree Walk EN2 0TJ Enfield Middlesex | British | 42996540001 | ||||||
| DUFFILL, Clare Marianne | Secretario | 91a Crystal Palace Road SE22 9EY London | British | 71005690004 | ||||||
| DUFFILL, Clare Marianne | Secretario | 91a Crystal Palace Road SE22 9EY London | British | 71005690004 | ||||||
| PATEL, Aurelia Azalea | Secretario | 50 Windsor Road RM8 3LA Dagenham Essex | British | 108784710001 | ||||||
| THOMAS, Francis George Northcott | Secretario | Sandfield Cottage St Nicolas Lane BR7 5LL Chislehurst Kent | British | 34191470001 | ||||||
| WATKINS, Simon Andrew | Secretario | 26 Pleasant Drive CM12 0JL London | British | 34048840002 | ||||||
| ALLPORT, Peter Francis | Director | 19 Saint Stephens Avenue AL3 4AA St. Albans Hertfordshire | British | 56488120002 | ||||||
| BIRCH, Henry Benedict | Director | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire England | United Kingdom | British | 51137400001 | |||||
| BURKE, Michael Ian | Director | Statesman House Stafferton Way SL6 1AY Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 148846850001 | |||||
| COLES, Pamela Mary | Director | 36 London End HP9 2JH Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980002 | ||||||
| CORMICK, Charles Bruce Arthur | Director | Flat 2 11 Pembridge Crescent W11 3DT London | United Kingdom | British | 17946190001 | |||||
| CORMICK, Charles Bruce Arthur | Director | Flat 2 11 Pembridge Crescent W11 3DT London | United Kingdom | British | 17946190001 | |||||
| DYSON, Ian | Director | Field House Manor Way, Knott Park KT22 0HS Oxshott Surrey | British | 50916710002 | ||||||
| FOWDEN, Jeremy Stephen Gary | Director | 53 Twyford Road Barrow On Trent DE73 1HA Derby Derbyshire | British | 94838910001 | ||||||
| GALLAGHER, Patrick James | Director | Thameside RG9 2LJ Henley On Thames 22 Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 77355310003 | |||||
| GILL, Peter Richard | Director | 30 Sheen Common Drive TW10 5BN Richmond Surrey | United Kingdom | British | 35996320004 | |||||
| JENNINGS, Clive Adrian Roynon | Director | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 79719890002 | |||||
| LATIF, Shahid | Director | 20 Crosier Way HA4 6HF Ruislip Middlesex | England | British | 6788550001 | |||||
| LAVINGTON, Michael John | Director | 16 Devonshire Lane 07945 Mendham New Jersey Usa | American | 56608760002 | ||||||
| MARGERRISON, Russell John | Director | 5 Wigwell Gardens Great Horwood MK17 0QX Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 170590800001 | |||||
| MARSHALL, Anthony | Director | 5 Brickhill Manor Court Watling Street, Little Brickhill MK17 9LN Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | 155979460001 | |||||
| MAY, Stuart Alexander | Director | Hathaway House Loudwater Lane Loudwater Rickmansworth Hertfordshire | British | 52890690001 | ||||||
| MEREDITH, Terence Herbert | Director | 8 Dickens Drive BR7 6RU Chislehurst Kent | British | 51444490001 | ||||||
| MURPHY, John Rowland | Director | Latymers 2 Victoria Road W5 1TB London | British | 6788530001 | ||||||
| NEWMAN, Keith Charles | Director | The Priory 12 High Street OX10 7HH Dorchester-On-Thames Oxfordshire | British | 56877000002 | ||||||
| PATEL, Aurelia Azalea | Director | 50 Windsor Road RM8 3LA Dagenham Essex | British | 108784710001 | ||||||
| RAY, Christine | Director | 1 Church Cottages Barracks Hill, Coleshill HP7 0LN Amersham Buckinghamshire | British | 56414060004 | ||||||
| RUSHTON, George Anthony | Director | West Winds Wix Hill KT24 6ED West Horsley Surrey | England | British | 26511450001 | |||||
| SOLOWAY, Stuart James | Director | 11 Broadwood Avenue HA4 7XS Ruislip Middlesex | England | British | 28343020001 | |||||
| THOMAS, Francis George Northcott | Director | Sandfield Cottage St Nicolas Lane BR7 5LL Chislehurst Kent | England | British | 34191470001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RANK HOLIDAYS DIVISION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank (U.K.) Holdings Limited | 28 jun 2017 | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Rank Leisure Holdings Limited | 06 abr 2016 | Stafferton Way SL6 1AY Maidenhead Statesman House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0