CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00728599 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
- Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción
¿Dónde se encuentra CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | PWC 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CARILLION INFRASTRUCTURE SERVICES LIMITED | 12 mar 2008 | 12 mar 2008 |
| ALFRED MCALPINE INFRASTRUCTURE SERVICES LIMITED | 10 may 2004 | 10 may 2004 |
| MCALPINE INFRASTRUCTURE SERVICES LIMITED | 07 oct 2003 | 07 oct 2003 |
| ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES LIMITED | 11 ene 2002 | 11 ene 2002 |
| KENNEDY UTILITY MANAGEMENT LIMITED | 02 nov 1998 | 02 nov 1998 |
| JOSEPH KENNEDY & CO.(MANCHESTER)LIMITED | 02 jul 1962 | 02 jul 1962 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2017 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2018 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 may 2018 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 31 may 2018 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 may 2017 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 22 jul 2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX el 01 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Carillion Utility Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como secretario el 25 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 18 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 04 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Daniel Easthope como director el 30 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Orden del tribunal para liquidar | 3 páginas | COCOMP | ||
Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Andrew Mark Davies como director el 14 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Daniel Easthope como director el 14 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 17 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Lee James Mills como director el 23 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nigel Paul Taylor como director el 29 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Martin Peter Routledge como director el 31 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Westley Maffei como secretario el 01 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Graham Michael Carr como director el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 01 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen William Hudson como director el 17 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 31 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Richard John Adam como director el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 17 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Andrew Mark | Director | Broad Street S1 2BQ Sheffield The Square United Kingdom | United Kingdom | British | 186650110002 | |||||
| FORSTER, Garry James | Secretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Secretario | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| KIRKIN, Richard William | Secretario | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | British | 1180700001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Secretario | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183570001 | |||||||
| TAPP, Richard Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| ARMSTRONG, Neil Patrick | Director | 4 Euxton Hall Gardens Euxton PR7 6PB Chorley Lancashire | Irish | 104897110001 | ||||||
| ATKINSON, Sarah Elizabeth | Director | 13 Milverton Drive Bramhall SK7 1EY Stockport Cheshire | British | 53216670002 | ||||||
| BEIRNE, Michael | Director | 52 Lock Road Broadheath WA14 4HD Altrincham Cheshire | British | 61171370001 | ||||||
| BROWN, Andrew Peter | Director | Furness Lodge Furness Field Off Werneth Low Road Gee Cross SK14 3AJ Hyde Cheshire | British | 61171450002 | ||||||
| CAROLAN, Peter Vincent | Director | 272 Leigh Road Worsley M28 1LF Manchester | Irish | 62299930001 | ||||||
| CARR, Graham Michael | Director | 550 Mauldeth Road West Chorlton-Cum-Hardy M21 7AA Manchester Lowry House United Kingdom | England | British | 154698170001 | |||||
| COCKER, Neil David | Director | 5 Rossett Close Kingsmead CW9 8WP Northwich Cheshire | England | British | 260158230001 | |||||
| COCLIFF, Stephen Jeffrey | Director | Coton Grange Coton Hill SY1 2PD Shrewsbury | England | British | 125427070002 | |||||
| COMER, Patrick Gerald | Director | 21 Buttermere Drive Hale Barns WA15 0ST Altrincham Cheshire | British | 1180680003 | ||||||
| CURLEY, Patrick Joseph | Director | Danley House Alders Land Disley Cheshire | Irish | 1180690001 | ||||||
| EASTHOPE, Daniel James | Director | 10-12 Russell Square Bloomsbury WC1B 5EH London Russell Square House United Kingdom | England | British | 239996840001 | |||||
| GARNER, Alan David | Director | 21 Sandy Lane LU7 3BE Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 76422880001 | ||||||
| GATES, Antony Richard | Director | 34 St Stephens Avenue AL3 4AD St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 165339210001 | |||||
| GLOVER, Michael John | Director | 88 Barkham Ride RG40 4ET Wokingham Berkshire | British | 50242550001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Director | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HOLMES, David Mark | Director | 57 Hatherop Road TW12 2RG Hampton Middlesex | United Kingdom | British | 115187480001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| HUDSON, Stephen William | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 78380050003 | |||||
| HUNT, Kenneth Edward | Director | 2 Fern Cottages Post Office Lane Norley WA6 8JW Frodsham Cheshire | British | 1180660002 | ||||||
| JACKSON, Andrew Philip | Director | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JONES, Peter Rudulph | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 173952430001 | |||||
| KENNEDY, Patrick James | Director | Mayo Brooks Drive Halebarns WA15 8TL Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 47720560001 | |||||
| KENYON, David | Director | 42 The Warings Heskin PR7 5NZ Chorley Lancashire | British | 37060690001 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| KIRKIN, Richard William | Director | 2 Redwood Close Woolston WA1 4EH Warrington Cheshire | England | British | 1180700001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Utility Services Group Limited | 06 abr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Construction cost account charge | Creado el 26 ago 2005 Entregado el 03 sept 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All of its right, title and interest in and to the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 13 ago 1997 Entregado el 16 ago 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Cash collateral security | Creado el 13 ago 1997 Entregado el 15 ago 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Assigns the charged account being the acount of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums in (whatever currency)together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 27 oct 1981 Entregado el 29 oct 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada UK 11,700 | |
Breve descripción Equitable charge over motor vehicles registration nos bmw 528I bmw 728I nja 743W nrj 553W. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed | Creado el 31 jul 1981 Entregado el 18 ago 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee suplemental to a debenture dated 1/2/72 | |
Breve descripción First fixed charge on all book debts & other debts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0