CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED

CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARILLION UTILITY SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00728599
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
    • Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    PWC
    8th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARILLION INFRASTRUCTURE SERVICES LIMITED12 mar 200812 mar 2008
    ALFRED MCALPINE INFRASTRUCTURE SERVICES LIMITED10 may 200410 may 2004
    MCALPINE INFRASTRUCTURE SERVICES LIMITED07 oct 200307 oct 2003
    ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES LIMITED11 ene 200211 ene 2002
    KENNEDY UTILITY MANAGEMENT LIMITED02 nov 199802 nov 1998
    JOSEPH KENNEDY & CO.(MANCHESTER)LIMITED02 jul 196202 jul 1962

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2017
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2018
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta17 may 2018
    Próxima declaración de confirmación vence31 may 2018
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta17 may 2017
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Domicilio social registrado cambiado de Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 22 jul 2019

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX el 01 oct 2018

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Carillion Utility Services Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como secretario el 25 jun 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 18 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 04 jun 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Daniel Easthope como director el 30 may 2018

    1 páginasTM01

    Orden del tribunal para liquidar

    3 páginasCOCOMP

    Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Andrew Mark Davies como director el 14 dic 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Daniel Easthope como director el 14 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    17 páginasAA

    Nombramiento de Mr Lee James Mills como director el 23 oct 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nigel Paul Taylor como director el 29 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Martin Peter Routledge como director el 31 jul 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Westley Maffei como secretario el 01 jul 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 30 jun 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Graham Michael Carr como director el 30 jun 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 01 ene 2017

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Stephen William Hudson como director el 17 abr 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 31 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard John Adam como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    17 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAVIES, Andrew Mark
    Broad Street
    S1 2BQ Sheffield
    The Square
    United Kingdom
    Director
    Broad Street
    S1 2BQ Sheffield
    The Square
    United Kingdom
    United KingdomBritish186650110002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Secretario
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    HIGGINS, Caroline Patricia
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    Secretario
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    British88102970001
    KIRKIN, Richard William
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    Secretario
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    British1180700001
    LEE, Christopher Michael
    Mill Road
    CM4 9BH Stock
    1
    Essex
    Secretario
    Mill Road
    CM4 9BH Stock
    1
    Essex
    British133709330001
    MAFFEI, Westley
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    235183570001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    ARMSTRONG, Neil Patrick
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Director
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Irish104897110001
    ATKINSON, Sarah Elizabeth
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    Director
    13 Milverton Drive
    Bramhall
    SK7 1EY Stockport
    Cheshire
    British53216670002
    BEIRNE, Michael
    52 Lock Road
    Broadheath
    WA14 4HD Altrincham
    Cheshire
    Director
    52 Lock Road
    Broadheath
    WA14 4HD Altrincham
    Cheshire
    British61171370001
    BROWN, Andrew Peter
    Furness Lodge Furness Field
    Off Werneth Low Road Gee Cross
    SK14 3AJ Hyde
    Cheshire
    Director
    Furness Lodge Furness Field
    Off Werneth Low Road Gee Cross
    SK14 3AJ Hyde
    Cheshire
    British61171450002
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Director
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    CARR, Graham Michael
    550 Mauldeth Road West
    Chorlton-Cum-Hardy
    M21 7AA Manchester
    Lowry House
    United Kingdom
    Director
    550 Mauldeth Road West
    Chorlton-Cum-Hardy
    M21 7AA Manchester
    Lowry House
    United Kingdom
    EnglandBritish154698170001
    COCKER, Neil David
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    Director
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish260158230001
    COCLIFF, Stephen Jeffrey
    Coton Grange
    Coton Hill
    SY1 2PD Shrewsbury
    Director
    Coton Grange
    Coton Hill
    SY1 2PD Shrewsbury
    EnglandBritish125427070002
    COMER, Patrick Gerald
    21 Buttermere Drive
    Hale Barns
    WA15 0ST Altrincham
    Cheshire
    Director
    21 Buttermere Drive
    Hale Barns
    WA15 0ST Altrincham
    Cheshire
    British1180680003
    CURLEY, Patrick Joseph
    Danley House
    Alders Land
    Disley
    Cheshire
    Director
    Danley House
    Alders Land
    Disley
    Cheshire
    Irish1180690001
    EASTHOPE, Daniel James
    10-12 Russell Square
    Bloomsbury
    WC1B 5EH London
    Russell Square House
    United Kingdom
    Director
    10-12 Russell Square
    Bloomsbury
    WC1B 5EH London
    Russell Square House
    United Kingdom
    EnglandBritish239996840001
    GARNER, Alan David
    21 Sandy Lane
    LU7 3BE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director
    21 Sandy Lane
    LU7 3BE Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British76422880001
    GATES, Antony Richard
    34 St Stephens Avenue
    AL3 4AD St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    34 St Stephens Avenue
    AL3 4AD St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish165339210001
    GLOVER, Michael John
    88 Barkham Ride
    RG40 4ET Wokingham
    Berkshire
    Director
    88 Barkham Ride
    RG40 4ET Wokingham
    Berkshire
    British50242550001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Director
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    HOLMES, David Mark
    57 Hatherop Road
    TW12 2RG Hampton
    Middlesex
    Director
    57 Hatherop Road
    TW12 2RG Hampton
    Middlesex
    United KingdomBritish115187480001
    HOWSON, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish147650310001
    HUDSON, Stephen William
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish78380050003
    HUNT, Kenneth Edward
    2 Fern Cottages
    Post Office Lane Norley
    WA6 8JW Frodsham
    Cheshire
    Director
    2 Fern Cottages
    Post Office Lane Norley
    WA6 8JW Frodsham
    Cheshire
    British1180660002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Director
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    JONES, Peter Rudulph
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandIrish173952430001
    KENNEDY, Patrick James
    Mayo Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TL Altrincham
    Cheshire
    Director
    Mayo Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TL Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish47720560001
    KENYON, David
    42 The Warings
    Heskin
    PR7 5NZ Chorley
    Lancashire
    Director
    42 The Warings
    Heskin
    PR7 5NZ Chorley
    Lancashire
    British37060690001
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    KIRKIN, Richard William
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    Director
    2 Redwood Close
    Woolston
    WA1 4EH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish1180700001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Director
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01521006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Construction cost account charge
    Creado el 26 ago 2005
    Entregado el 03 sept 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its right, title and interest in and to the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ashall Homes Limited
    Transacciones
    • 03 sept 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 13 ago 1997
    Entregado el 16 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities for the time being, owing or incurred by the obligors (as defined therein) to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined therein) and/or on any other account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(For Itself and as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 16 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Cash collateral security
    Creado el 13 ago 1997
    Entregado el 15 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assigns the charged account being the acount of the company with the depository (being the royal bank of scotland international limited) which account is blocked or designated as charged to the bank and the deposit being all sums at the date of the cash collateral security or thereafter standing to the credit of the charged account together with all interest and other amounts accruing on such sums in (whatever currency)together with all the rights titles and benefits of the company whatsoever present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 27 oct 1981
    Entregado el 29 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    UK 11,700
    Breve descripción
    Equitable charge over motor vehicles registration nos bmw 528I bmw 728I nja 743W nrj 553W.
    Personas con derecho
    • Savings & Investment Bank Limited
    Transacciones
    • 29 oct 1981Registro de una carga
    Deed
    Creado el 31 jul 1981
    Entregado el 18 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee suplemental to a debenture dated 1/2/72
    Breve descripción
    First fixed charge on all book debts & other debts.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transacciones
    • 18 ago 1981Registro de una carga

    ¿Tiene CARILLION UTILITY SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 ene 2018Fecha de la petición
    26 ene 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profesional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0