00735317 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresa00735317 LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00735317
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de 00735317 LIMITED?

    • (4521) /

    ¿Dónde se encuentra 00735317 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de 00735317 LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2010
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2011
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para 00735317 LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta31 may 2017
    Próxima declaración de confirmación vence14 jun 2017
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para 00735317 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para 00735317 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Restauración por orden judicial - anteriormente en liquidación voluntaria de acreedores

    4 páginasREST-CVL

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed holloway white allom\certificate issued on 11/01/21
    páginasCERTNM

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    22 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2019

    22 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2018

    22 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2017

    19 páginas4.68

    Presentación de insolvencia

    INSOLVENCY:secretary of state's release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Renuncia de un liquidador

    1 páginas4.33

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:order of court in respect of replacement liquidator
    6 páginasLIQ MISC OC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 feb 2016

    19 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Komg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL a 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL el 17 jun 2015

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a Komg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL el 22 may 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2015

    17 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2014

    18 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Informe de progreso del administrador hasta 25 feb 2013

    22 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 04 abr 2012

    21 páginas2.24B

    Cese del nombramiento de Nigel Diver como secretario

    1 páginasTM02

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    36 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    15 páginas2.16B

    ¿Quiénes son los directivos de 00735317 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COLE, Robert Terry
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishCompany Director82282430001
    HAILEY, Mark Crompton
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishDirector121769160001
    KEATING, Stephen Charles
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishDirector152085790001
    OIRSCHOT, Richard Anthony
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishDirector153410900001
    DIVER, Nigel James
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    Secretario
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    BritishFinance84312990002
    FEATHERSTONE, Derek William
    33 Somersham
    Bridlewood Panshanger
    AL7 2PZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    33 Somersham
    Bridlewood Panshanger
    AL7 2PZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary38485580001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    PRAIN, Ronald
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    British2864720001
    SPRIGGS, Peter John
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British11339380001
    ARDERN, Derrick
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor44478670001
    BARNES, David Arthur Robert
    2 Victoria Road
    TW1 3HW Twickenham
    Middlesex
    Director
    2 Victoria Road
    TW1 3HW Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director28481590001
    BREED, Barry Tony
    Vesta Avenue
    AL1 2PF St. Albans
    26
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Vesta Avenue
    AL1 2PF St. Albans
    26
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishConstruction140305440002
    COLGATE, Benjamin John
    Giddygreen 34 Sandyhurst Lane
    TN25 4NS Ashford
    Kent
    Director
    Giddygreen 34 Sandyhurst Lane
    TN25 4NS Ashford
    Kent
    United KingdomBritishMarketing116271550001
    COLLINS, Paul David
    21 Onslow Road
    KT3 4AR New Malden
    Surrey
    Director
    21 Onslow Road
    KT3 4AR New Malden
    Surrey
    BritishCompany Director28481600003
    COWEN, Michael Richard
    27 Addison Way
    NW11 6AL London
    Director
    27 Addison Way
    NW11 6AL London
    BritishCertified Accountant67834500002
    CROSSMAN, Brian Robert
    3 Badgers Walk
    Tewin
    AL6 0HP Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    3 Badgers Walk
    Tewin
    AL6 0HP Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCommercial84313470002
    DAVENPORT, Simon
    Fishpool Street
    AL3 4RX St Albans
    56
    Herts
    Director
    Fishpool Street
    AL3 4RX St Albans
    56
    Herts
    BritishDirector129728380001
    DAVIES, John Leighton
    Ferncroft Mapledrakes Road
    GU6 7QW Ewhurst
    Surrey
    Director
    Ferncroft Mapledrakes Road
    GU6 7QW Ewhurst
    Surrey
    BritishChief Estimator60507760001
    DEAN, John Michael
    Charlwood Cottage Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Surrey
    Director
    Charlwood Cottage Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Surrey
    BritishChief Surveyor28481620001
    DIVER, Nigel James
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    Director
    10 Holbrook Gardens
    WD25 8AB Aldenham
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance84312990002
    DUNN, James Christopher
    54 Oxford Drive
    SE1 2FB London
    Director
    54 Oxford Drive
    SE1 2FB London
    BritishConstruction28529460003
    EDNIE, Derek Angus
    3 Vicarage Lane
    Dunton Green
    TN13 2TP Sevenoaks
    Kent
    Director
    3 Vicarage Lane
    Dunton Green
    TN13 2TP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director46123240001
    ERRINGTON, Paul John
    1 Hazlemere Road
    Penn
    HP10 8AA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    1 Hazlemere Road
    Penn
    HP10 8AA High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector28481630001
    EWER, Adrian James Henry
    Blagdens House Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    Director
    Blagdens House Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishChartered Accountant33196010002
    GILES, Phillip Peter
    17 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Director
    17 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    BritishQuantity Surveyor41677700001
    HOCKLEY, John Edward
    The Cottage
    Main Street Akeley
    MK18 5HR Buckingham
    Bucks
    Director
    The Cottage
    Main Street Akeley
    MK18 5HR Buckingham
    Bucks
    United KingdomBritishManaging Director30434730001
    JONES, Ian Benbow
    11 Woodbury Park Road
    Ealing
    W13 8DD London
    Director
    11 Woodbury Park Road
    Ealing
    W13 8DD London
    United KingdomBritishConstruction108331280002
    MOORE, Steven John
    Heathmoor House
    47 Pinfold Pond
    Woburn
    Bedfordshire
    Director
    Heathmoor House
    47 Pinfold Pond
    Woburn
    Bedfordshire
    BritishDirector10662610001
    PRAIN, Ronald
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    Director
    19 Cross Deep Gardens
    TW1 4QZ Twickenham
    Middlesex
    BritishAccountant2864720001
    RANKIN, David Douglas
    20 Marriotts Way
    Haddenham
    HP17 8BW Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    20 Marriotts Way
    Haddenham
    HP17 8BW Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director43928310001
    RICHARDSON, Brian
    Hylle House
    Pound Hill
    MK17 9AS Great Brickhill
    Buckinghamshire
    Director
    Hylle House
    Pound Hill
    MK17 9AS Great Brickhill
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director109836750001
    SHEPHERD, Martyn Alan
    1 Carteret Close
    Willen
    MK15 9LD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    1 Carteret Close
    Willen
    MK15 9LD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishQuantity Surveyor106456400001
    SIZE, Darren Thomas
    Ainsdale Road
    W5 1JY London
    31
    Director
    Ainsdale Road
    W5 1JY London
    31
    EnglandIrishDirector129728000001
    SPRIGGS, Peter John
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    59 Crofts Path
    HP3 8HE Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishAccountant11339380001
    VARLEY, David Gordon
    The Paddock House West Common
    SL9 7QN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    The Paddock House West Common
    SL9 7QN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector Of Companies28481640001

    ¿Tiene 00735317 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 14 feb 2011
    Entregado el 17 feb 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property comprising parts of the basement ground floor and first floor of 43 south audley street london and the basement showroom in adams mews westminster t/no LN14336; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery, equipment. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Reward Capital Limited
    Transacciones
    • 17 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 02 jun 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 08 ene 2010
    Entregado el 22 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from hwa group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Matrix Private Equity Partners LLP as Security Trustee
    Transacciones
    • 22 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal assignment of key man policies
    Creado el 28 ago 2008
    Entregado el 09 sept 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rights title interest and benefit in and to the key man policies being; 70C19U56, st james's place UK PLC, philip haydn whitehead, £400,000, 71C06P23 st james's place UK PLC robert terry cole £1,000,000, 90070383, phoenix life limited, nigel driver, £234,312. see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2008Registro de un cargo (395)
    Deed of counter indemnity
    Creado el 05 abr 2008
    Entregado el 15 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All property assets and undertaking including the l/h premises parts of the basement ground floor and first floor of 43 south audley street and the basement showroom in adams mews london t/no LN14336 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Zurich Gsg Limited
    Transacciones
    • 15 abr 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 05 abr 2008
    Entregado el 11 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 02 jun 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Legal charge
    Creado el 10 ago 2005
    Entregado el 24 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H land comprising parts of the basement ground floor and first floor of 43 south audley street and the basement showroom in adams mews westminster t/n LN14336 and all buildings plant and machinery all additions and improvements and all the estate or interest all monies from time to time payable under or pursuant to the insurances including without limitation the refund of any premiums and first floating charge all moveable machinery equipment and furniture on or at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Zurich Gsg Limited
    Transacciones
    • 24 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage deed
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a 43 south audley street grosvenor square london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Account management agreement
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All sums standing to the credit of the account and numbered 01118165.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture deed
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    An omnibus letter of set off
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or hwa limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums standing to the credit of the account.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assigns all money including bonuses, the benefit of all options and rights under or in connection with the policy numbered 27C82G83 and in the name of robert cole. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of acompany
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assigns all money including bonuses, the benefit of all options and rights under or in connection with the policy numbered F3347455 in the name of nigel james diver. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assigns all money including bonuses, the benefit of all options and rights under or in connection with the policy numbered F3347535 and in the name of brian robert crossman. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 19 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assigns all monies including bonuses, all option and rights under or in connection with the policy numbered 27C82E84 in the name of philip whitehead. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and fixed and floating security document (the "security document")
    Creado el 22 oct 2001
    Entregado el 08 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,debts and liabilities whatsoever due or to become due from the company to any beneficiary (as defined) under the guarantee and the group financing documents (as defined) and the security document
    Breve descripción
    Including (I) millmarsh lane,enfield EN3 7AG; ngl 5924; (ii) sowton 30,sidmouth rd,exeter; dn 407452; (iii old railway works,newton rd,ashford (all freehold ) plus other properties listed; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 08 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 06 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene 00735317 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 oct 2011Inicio de la administración
    01 mar 2013Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    William James Wright
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profesional
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    FechaTipo
    01 mar 2013Inicio de la liquidación
    11 oct 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David John Standish
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Howard Smith
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0