ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED

ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00755613
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ATKINS CONSULTANTS LIMITED01 jun 200401 jun 2004
    WS ATKINS CONSULTANTS LIMITED12 abr 198912 abr 1989
    W.S.ATKINS & PARTNERS29 mar 196329 mar 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 18 abr 2024

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Modification des détails de Ws Atkins Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 oct 2023

    2 páginasPSC05

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed atkins consultants LIMITED\certificate issued on 12/10/23
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name12 oct 2023

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 11 oct 2023

    RES15

    Declaración de confirmación presentada el 20 sept 2023 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    5 páginasAA

    Notification de Ws Atkins Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 dic 2022

    2 páginasPSC02

    Cessation de Parfab Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 dic 2022

    1 páginasPSC07

    Cessation de Confab Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 dic 2022

    1 páginasPSC07

    Declaración de confirmación presentada el 20 sept 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alan James Cullens como director el 07 abr 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 20 sept 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    5 páginasAA

    Nombramiento de Joanne Jarman como director el 17 may 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Stephen Anderson como director el 17 may 2021

    1 páginasTM01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Woodcote Grove Ashley Road Epsom Surrey KT18 5BW

    1 páginasAD04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 20 sept 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCALLISTER, Louise Mary
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    238795760001
    NOBELEN, Elliot Michael
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    238796420001
    COLE, Simon Glenister
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Director
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish146000480001
    JARMAN, Joanne
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Director
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish283434280001
    BAKER, Helen Alice
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Secretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British108742050002
    DAVID, Katie Charmian
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    British73696680003
    DAVIS, Philip Stephen James
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    Secretario
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    British71932630003
    GERRARD, Ashley Louise
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    218094750001
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Secretario
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    HAYLOCK, Colin Peter
    Downside The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    Secretario
    Downside The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    British47687610001
    LINDSAY, Catherine Elizabeth
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    218252890001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Secretario
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    TOMALIN, Richard Howarth
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    Secretario
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    British13199870002
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Secretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British85595860003
    ANDERSON, Mark Stephen
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Director
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish122463830003
    ARCHER, Paul Edward
    15 Woodgavil
    SM7 1AA Banstead
    Surrey
    Director
    15 Woodgavil
    SM7 1AA Banstead
    Surrey
    British43573300001
    BALFE, Philip Joseph
    White Lodge
    Rectory Drive
    GU6 7PX Ewhurst
    Surrey
    Director
    White Lodge
    Rectory Drive
    GU6 7PX Ewhurst
    Surrey
    British29923830001
    BALL, Geoffrey Robert
    Dial Cottage
    Church Lane Sevenhampton
    GL54 5SW Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Dial Cottage
    Church Lane Sevenhampton
    GL54 5SW Cheltenham
    Gloucestershire
    British83110540001
    BARRETT, Richard John, Bsc, Ceng, Mice
    Meadows End
    Hilliers Lane
    BS25 5NA Churchill
    North Somerset
    Director
    Meadows End
    Hilliers Lane
    BS25 5NA Churchill
    North Somerset
    EnglandBritish121534930001
    BARROW, Jill Helen
    Blackslade Manor
    Widecombe In The Moor
    TQ13 7TF Devon
    Director
    Blackslade Manor
    Widecombe In The Moor
    TQ13 7TF Devon
    British82386630001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Director
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BINNIE, Christopher Jon Anthony
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    Director
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    British14298460001
    BROWN, Peter Allan
    Warren Road
    GU1 2HG Guildford
    48
    Surrey
    Director
    Warren Road
    GU1 2HG Guildford
    48
    Surrey
    British30520670001
    BROWNE, Maximilian George Burrowes
    Knockcree
    Mahee Island Comber N1
    BT23 6EP
    County Down
    Director
    Knockcree
    Mahee Island Comber N1
    BT23 6EP
    County Down
    British19130630001
    BROYD, Timothy William, Professor
    2 Hillbury Gardens
    CR6 9TQ Warlingham
    Surrey
    Director
    2 Hillbury Gardens
    CR6 9TQ Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish58859990001
    BUSBY, Peter Leonard
    8 The Common
    Ealing
    W5 3TR London
    Director
    8 The Common
    Ealing
    W5 3TR London
    British44813100001
    CATTO, Ivor Douglas
    Highfields
    KT21 2NL Ashtead
    12
    Surrey
    Director
    Highfields
    KT21 2NL Ashtead
    12
    Surrey
    United KingdomBritish87066030002
    CLARK, Piers Benedict, Dr
    61 Downs Wood
    KT18 5UJ Epsom Downs
    Surrey
    Director
    61 Downs Wood
    KT18 5UJ Epsom Downs
    Surrey
    United KingdomBritish84765290001
    CLARKE, Keith Edward
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Director
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish93106530002
    CLEMENTS, David Russell
    Southernhay
    High Street
    TA17 8SE Hinton St George
    Somerset
    Director
    Southernhay
    High Street
    TA17 8SE Hinton St George
    Somerset
    United KingdomBritish22250060002
    COLLINS, Rodney
    The Bothy
    Forest Road
    KT24 5ER East Horsley
    Surrey
    Director
    The Bothy
    Forest Road
    KT24 5ER East Horsley
    Surrey
    British12906160001
    CORRIE, Robert Keith
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    Director
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish35957190001
    CULLENS, Alan James
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Director
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish189297280001
    CUMING, James Anthony
    74 Chenies Mews
    WC1E 6HU London
    Director
    74 Chenies Mews
    WC1E 6HU London
    EnglandBritish19130650002
    CUTHBERT, Richard Harry
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    Director
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    United KingdomBritish43573230002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    England
    14 dic 2022
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England & Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01885586
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro755561
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro755581
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second fixed and floating debenture
    Creado el 27 feb 2003
    Entregado el 11 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Breve descripción
    The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 11 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 18 dic 2002
    Entregado el 27 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Breve descripción
    Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 27 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security assignment in respect of the shepherd contracts
    Creado el 20 mar 2002
    Entregado el 28 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The assignor with full title guarantee, as continuing security for the performance and payment of all the secured obligations, hereby assigns and agrees to assign to the assignee all of its right, title, benefit and interest whatsoever present and future in: (a) clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract; and (b) the guarantee insofar as it relates to the contractor's obligations under clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract.
    Personas con derecho
    • TS4I (Process Utilities 1) Limited
    Transacciones
    • 28 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sharge charge (created by CUBIC (UK) limited, E.D.S. international limited, international computers limited and W.S. atkins consultants limited)
    Creado el 13 ago 1998
    Entregado el 21 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from transaction systems limited (the "company") to the chargee in its capacity as security agent (under the terms of the security trust deed as therein defined)) under any bank finance document (as therein defined) or in connection with the facilities on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge all future shares and dividends meaning: all dividends payable and other distributions in relation to any of the shares being all of the shareholders' present and future interest in and to the ordinary shares in the company detailed in schedule 1 of the share charge and any other shares issued by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America International Limited
    Transacciones
    • 21 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creado el 04 ene 1996
    Entregado el 18 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from bridgend custodial services limited to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the mortgage of shares contravening section 151 of the companies act 1985
    Breve descripción
    All dividends paid or payable on the shares being:- 24,000 "a" shares and 1,000 "b" shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 08 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit agreement
    Creado el 05 mar 1992
    Entregado el 10 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a guarantee of even date and in respect of the deposit agreement.
    Breve descripción
    All rights to the repayment of the deposit (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 10 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral mortgage
    Creado el 14 jun 1988
    Entregado el 28 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from atkins properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86
    Breve descripción
    L/H property k/a premises on the third floor of the western wing of sir william atkins house, southern link road epsom, surrey together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 28 jun 1988Registro de una carga
    Collateral mortgage
    Creado el 21 abr 1988
    Entregado el 10 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86
    Breve descripción
    All the l/h property k/a the western wing of sir william atkins house, southern link road, epsom together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery and the full benefit of the covenants and guarantee on the part of the company contained in the lease dated 4/3/88.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 10 may 1988Registro de una carga
    Collateral mortgage
    Creado el 30 ene 1987
    Entregado el 18 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all moneys due or to become due from scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of subsititution dated 13/7/86
    Breve descripción
    All the l/h property demised to the company by the lease or underlease (please see form 395 for full details of property) together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time therein.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC.
    Transacciones
    • 18 feb 1987Registro de una carga
    • 16 mar 1991Registro de una carga
    Collateral mortgage
    Creado el 13 jun 1986
    Entregado el 19 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/86.
    Breve descripción
    Land and buildings situate to the west of and having access to ashley road, epsom, surrey and continuing to chalk lane on the east and k/a woodcote grove, title no:- p 17436 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 19 jun 1986Registro de una carga
    Charge
    Creado el 25 abr 1985
    Entregado el 02 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts and other debts due owing or incurred to the company.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company.
    Transacciones
    • 02 may 1985Registro de una carga
    • 06 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 07 ago 1963
    Entregado el 13 ago 1963
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property including uncalled capital. (See doc 6).
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank LTD.
    Transacciones
    • 13 ago 1963Registro de una carga
    • 06 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0