FURNIVAL ESTATES LIMITED

FURNIVAL ESTATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFURNIVAL ESTATES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00758082
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2013

    Estado de capital el 02 sept 2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    16 páginasAA

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2011

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2010

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    14 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cambio de datos del director Christopher George White el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Maurice Moses Benady el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    15 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secretario corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Director
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Director
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Director
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Director
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Director
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ¿Tiene FURNIVAL ESTATES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 19 sept 2007
    Entregado el 26 sept 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transacciones
    • 26 sept 2007Registro de un cargo (395)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creado el 28 ene 2002
    Entregado el 06 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The leasehold land known as land ajoining eyre street, furnival street, matilda way and matilda street, sheffield. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Creado el 03 ago 1999
    Entregado el 16 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 06 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £87,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deed
    Breve descripción
    Together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon (for full details of charge see form 395 and contd sheet).
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transacciones
    • 06 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental charge deed
    Creado el 04 dic 1992
    Entregado el 08 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Redvers house union street sheffield south yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transacciones
    • 08 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 oct 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 jul 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 21 nov 1990
    Entregado el 29 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Redvers marse furnival street sheffield t/n: ywe 60547 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1990Registro de una carga
    • 15 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Further charge
    Creado el 19 sept 1978
    Entregado el 20 sept 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,240,000 and all other monies due or to become due from evans of leeds limited to the chargee under the terms of a deed dated 17-6-61.
    Breve descripción
    Land and buildings situate in sheffield being furnival house, furnival gate, as comprised in a lease dated 15-11-65.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transacciones
    • 20 sept 1978Registro de una carga
    • 27 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 30 jun 1975
    Entregado el 02 jul 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Redvers slouse, furnival street, sheffield. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Coventry Bank LTD
    Transacciones
    • 02 jul 1975Registro de una carga
    • 08 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Dep of title deed w/i
    Creado el 23 dic 1971
    Entregado el 28 dic 1971
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £650,000
    Breve descripción
    Property at junction of union st and furnival gate, sheffield, known as redvers house.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 28 dic 1971Registro de una carga
    • 08 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A registered charge
    Creado el 17 jun 1971
    Entregado el 28 jun 1971
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,335,000 & all other monies due or to become due from evans of leeds LTD to the chargee any account whatsoever.
    Breve descripción
    Furnival house, furnival gate, sheffield comprised in a lease dated 15/11/65.
    Personas con derecho
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transacciones
    • 28 jun 1971Registro de una carga
    • 27 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 dic 1970
    Entregado el 08 dic 1970
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £800,000 due from lonsdale properties LTD to the chargers and for further securing £700,000 outstanding under 2 charges dated respectively 24/06/68 and 30/12/68 and due from the company millshaw property co. LTD and mulgate investments LTD to the chargee.
    Breve descripción
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way and matilda st, sheffield known as furnival house.
    Personas con derecho
    • Old Broad Street Securiting LTD
    Transacciones
    • 08 dic 1970Registro de una carga
    • 08 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 dic 1968
    Entregado el 09 ene 1969
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £427,000 & further securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68, all due from the company and the three other companies referred to therein
    Breve descripción
    Land containing 891 square yards at the junction of furnival st & union lane in the city of sheffield.
    Personas con derecho
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transacciones
    • 09 ene 1969Registro de una carga
    • 08 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 dic 1968
    Entregado el 09 ene 1969
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £427,000 & furthe securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68. all due from the company and three other companies referred to therein.
    Breve descripción
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way, & matilda st, sheffield. 4833 square yards approx.
    Personas con derecho
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transacciones
    • 09 ene 1969Registro de una carga
    • 08 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 jun 1968
    Entregado el 28 jun 1968
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Securing £345,000 and all other monies due or to become due from the co, to the chargee on any{ account whatsoever
    Breve descripción
    Land adjoining eyre street,furnival street matilda way and matilda street sheffield together with the buildings erected thereon. (See doc 20).
    Personas con derecho
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transacciones
    • 28 jun 1968Registro de una carga
    • 08 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0