GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00761460 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Mclaughlan como director el 01 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mary Elizabeth Bourlet como secretario el 01 feb 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Laura Harradine-Greene como secretario el 01 feb 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 25 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mary Elizabeth Murray el 12 may 2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 03 abr 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Matthew King como director el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mary Elizabeth Murray como secretario el 25 ago 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación para la terminación de Nils Olin Steinmeyer como director | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Segunda presentación para la terminación de Kevin Michael Bradshaw como director | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Justin Matthew King como director el 18 ago 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Thomas Murphy como director el 18 ago 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 22 jul 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Thomas Murphy como director el 06 abr 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Roger Mclaughlan como director el 10 mar 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nils Olin Steinmeyer como director el 06 abr 2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRADINE-GREENE, Laura | Secretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 242724460001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950002 | |||||
| ALLAN, John Michael | Secretario | 37 Cavendish Drive Claygate KT10 0QE Esher Surrey | British | 17536370001 | ||||||
| BOURLET, Mary Elizabeth | Secretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 217311710002 | |||||||
| COX, Peter John | Secretario | 57 Gleneldon Road Streatham SW16 2BH London | British | 58964650001 | ||||||
| JONES, Anthony David | Secretario | 14 Brownhill Crescent LE7 7LA Rothley Leicestershire | British | 73622510001 | ||||||
| MURFIN, Stephen | Secretario | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | 8690590001 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Secretario | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| SOUTHWELL, Alan David | Secretario | 41 Rectory Lane Byfleet KT14 7LR West Byfleet Surrey | British | 17536350001 | ||||||
| ALLAN, John Michael | Director | 37 Cavendish Drive Claygate KT10 0QE Esher Surrey | British | 17536370001 | ||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRIGDEN, Peter | Director | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| CHARLTON, John Fraser | Director | 4 Selwood Place SW7 3QQ London | British | 17536360001 | ||||||
| COX, Peter John | Director | 57 Gleneldon Road Streatham SW16 2BH London | British | 58964650001 | ||||||
| FAVELL, Gary Alan | Director | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | 107699240001 | |||||
| FISHER, Guy Norman | Director | 1 Beverley Road SW13 0LX London | United Kingdom | British | 17536380002 | |||||
| HEWITT, Robert John | Director | The Old Cider Mill 2 Cotts Farm Cotts Lane HR1 3ND Lugwardine Herefordshire | United Kingdom | British | 15486070002 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Director | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Director | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| KING, Justin Matthew | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 213043730001 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Director | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Director | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Director | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MCINTYRE, Duncan Keith | Director | 24 Rounton Road Church Crookham GU13 0HB Fleet Hampshire | British | 29885580001 | ||||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| MURFIN, Stephen | Director | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | 8690590001 | ||||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Director | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| PRICE, Glyn John | Director | Mill End Ash Ingen Mews Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | 73470720001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Director | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Director | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEVENSON, Barry John | Director | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | 102595670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyevale Garden Centre Holdings Limited | 06 abr 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 24 feb 2009 Entregado el 04 mar 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 23 feb 1995 Entregado el 06 mar 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 23 feb 1995 Entregado el 06 mar 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold property known as land lying to the north east of rousebarn lane chandlers cross hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 183142. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 23 feb 1995 Entregado el 06 mar 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold property known as marlow garden centre (formerly thames valley garden centre) little marlow buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 23 feb 1995 Entregado el 06 mar 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold property known as palmers nurseries fir tree hill chandlers cross sarratt hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 92718. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0