STOCKDALE SECURITIES LIMITED

STOCKDALE SECURITIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTOCKDALE SECURITIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00762818
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra STOCKDALE SECURITIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WESTHOUSE SECURITIES LIMITED31 ene 201231 ene 2012
    ARBUTHNOT SECURITIES LIMITED27 ene 200327 ene 2003
    OLD MUTUAL SECURITIES LTD11 nov 200211 nov 2002
    GNI FINANCIAL PRODUCTS LIMITED08 sept 199708 sept 1997
    GNI WALLACE LIMITED14 may 198614 may 1986
    JOHNSON MATTHEY & WALLACE LIMITED08 jul 198208 jul 1982
    WALLACE BROTHERS COMMODITES LIMITED31 may 196331 may 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STOCKDALE SECURITIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    14 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 ene 2022

    17 páginasLIQ03

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Domicilio social registrado cambiado de Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY a Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane London N12 8LY el 16 feb 2021

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Cassini House 57 st. James's Street London SW1A 1LD England a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY el 27 ene 2021

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 11 ene 2021

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2020 con actualizaciones

    8 páginasCS01

    Notification de Shore Capital Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2019

    2 páginasPSC02

    Cessation de Somers Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2019

    1 páginasPSC07

    Cambio de datos del director Mr Andrew Beauchamp Proctor el 01 jul 2019

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Clive Black como director el 10 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Finlay Brown como director el 10 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Dru Danford como director el 10 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew John Crossley como director el 29 oct 2019

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 100 Wood Street London EC2V 7AN England a Cassini House 57 st. James's Street London SW1A 1LD el 12 jul 2019

    1 páginasAD01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2019 au 31 dic 2019

    1 páginasAA01

    Resoluciones

    Resolutions
    12 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Purchase agreement 18/03/2019
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Dr Clive Black como director el 31 mar 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Dru Danford como director el 31 mar 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon Fine como director el 31 mar 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alexander Mark Butcher como director el 31 mar 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Louise Catherine Nash como director el 31 mar 2019

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    46 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PROCTOR, Andrew Beauchamp
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Secretario
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    219735070001
    FINE, Simon
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Director
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritishInvestment Banker257291330001
    PROCTOR, Andrew Beauchamp
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    Director
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    United KingdomBritishFinance Director171347190001
    AZIS, Jonathan Giles Ashley
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Westwood Manor
    Wiltshire
    United Kingdom
    Secretario
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Westwood Manor
    Wiltshire
    United Kingdom
    167417280001
    BUTLER, Nicola
    5th Floor
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Heron Tower
    United Kingdom
    Secretario
    5th Floor
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Heron Tower
    United Kingdom
    177417540001
    FOLEY, Grant Jeffrey
    Meadowside Road
    RM14 3YT Upminster
    10
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    Meadowside Road
    RM14 3YT Upminster
    10
    Essex
    United Kingdom
    174154280001
    KAYE, Jeremy Robin
    Mallards 52 Moat Road
    RH19 3LH East Grinstead
    West Sussex
    Secretario
    Mallards 52 Moat Road
    RH19 3LH East Grinstead
    West Sussex
    British9887470001
    MAYOR, Sukesh Chander
    62 Herbert Road
    Emerson Park
    RM11 3LL Hornchurch
    Essex
    Secretario
    62 Herbert Road
    Emerson Park
    RM11 3LL Hornchurch
    Essex
    British72392270001
    TELFER, Miranda Lauraine
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    Secretario
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    British80083220001
    WADE, John Leonard
    Willow Park
    RH16 3UA Haywards Heath
    15
    West Sussex
    United Kingdom
    Secretario
    Willow Park
    RH16 3UA Haywards Heath
    15
    West Sussex
    United Kingdom
    British166249760001
    WALLIS, Nicholas Charles
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    British4190770001
    WOYDA, Jeffrey David
    Partingdale Manor
    Partingdale Lane Mill Hill
    NW7 1NS London
    Secretario
    Partingdale Manor
    Partingdale Lane Mill Hill
    NW7 1NS London
    British116885950001
    AIREY, Christopher Jonathan
    Little Newarks Newarks Road
    Good Easter
    CM1 4SA Chelmsford
    Essex
    Director
    Little Newarks Newarks Road
    Good Easter
    CM1 4SA Chelmsford
    Essex
    BritishChief Executive45740380001
    ANGEST, Henry, Sir
    Thurloe Square
    SW7 2SR London
    40
    Director
    Thurloe Square
    SW7 2SR London
    40
    EnglandBritishCompany Director6681230002
    AZIS, Jonathan Giles Ashley
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Westwood Manor
    Wiltshire
    United Kingdom
    Director
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Westwood Manor
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector71198840001
    BISHOP, James Anthony William
    14 Grosvenor Gardens
    East Sheen
    SW14 8BY London
    Director
    14 Grosvenor Gardens
    East Sheen
    SW14 8BY London
    United KingdomBritishHead Of Small Cap Sales34341980002
    BLACK, Clive, Dr
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    Director
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    EnglandBritishInvestment Banker257295590001
    BLOMFIELD SMITH, Rosamund Evelyn
    60 Prince Of Wales Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4BH London
    Director
    60 Prince Of Wales Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4BH London
    EnglandBritishBanker79358960001
    BROWN, Mark Finlay
    Wood Street
    EC2V 7AN London
    100
    England
    Director
    Wood Street
    EC2V 7AN London
    100
    England
    EnglandBritishStock Broker198398730001
    BROWN, Mark Finlay
    Holywell House
    Holywell East Coker
    BA22 9NQ Yeovil
    Somerset
    Director
    Holywell House
    Holywell East Coker
    BA22 9NQ Yeovil
    Somerset
    EnglandBritishBanker98410300001
    BUTCHER, Alexander Mark
    Wood Street
    EC2V 7AN London
    100
    England
    Director
    Wood Street
    EC2V 7AN London
    100
    England
    United KingdomBritishNon Executive Director175730040001
    BUTLER, Robert Keith
    Meadow Way
    IG7 6LP Chigwell
    12
    Essex
    United Kingdom
    Director
    Meadow Way
    IG7 6LP Chigwell
    12
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector26071610002
    CANWELL, Stuart
    Springfield House
    22 Springfield Grove
    TW16 6NT Sunbury On Thames
    Middlesex
    Director
    Springfield House
    22 Springfield Grove
    TW16 6NT Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishBroker141825210001
    COBB, James Robert
    12 The Deerings
    AL5 2PE Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    12 The Deerings
    AL5 2PE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant122932220001
    CROSSLEY, Andrew John
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    Director
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    EnglandBritishStockbroker106084170001
    CULL, Graeme Frank
    Strathbeg 6 Park Road
    GU22 7BW Woking
    Surrey
    Director
    Strathbeg 6 Park Road
    GU22 7BW Woking
    Surrey
    BritishStockbroker62391710001
    DANFORD, Dru
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    Director
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    EnglandBritishInvestment Banker257295410001
    DAVIES, Mark Edward Trehearne
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    Director
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    EnglandBritishCommodity Broker82536300001
    DAVIES, Stephen Arthur James
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    Director
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    BritishSettlements Manager73623020001
    DONALDSON, Nicholas John
    22 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    Director
    22 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    United KingdomBritishInvestment Banker29510010002
    FINLAY, Robert James Dundas
    15 St Botolph Street
    EC3A 7BB London
    Beaufort House
    United Kingdom
    Director
    15 St Botolph Street
    EC3A 7BB London
    Beaufort House
    United Kingdom
    United KingdomBritishStockbroker116483900001
    FLETCHER, Piers Michael William
    Blackberry Farm Winterslow
    SP5 1QP Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Blackberry Farm Winterslow
    SP5 1QP Salisbury
    Wiltshire
    BritishCommodity Broker12056130007
    FOLEY, Grant Jeffrey
    Meadowside Road
    RM14 3YT Upminster
    10
    Essex
    Director
    Meadowside Road
    RM14 3YT Upminster
    10
    Essex
    United KingdomBritishChartered Accountant134335660001
    FRASER, Craig James, Dr
    20 Ropemaker Street
    EC2Y 9AR London
    Arbuthnot House
    Director
    20 Ropemaker Street
    EC2Y 9AR London
    Arbuthnot House
    EnglandBritishHead Of Research166816980001
    GETLEY, Christopher Dewar
    Weston
    NN12 8PU Towcester
    Hall Farm
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Weston
    NN12 8PU Towcester
    Hall Farm
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector91704460001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Shore Capital Group Plc
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    01 abr 2019
    57 St. James's Street
    SW1A 1LD London
    Cassini House
    England
    No
    Forma jurídicaCompany
    País de registroEngland
    Autoridad legalEnglish
    Lugar de registroRegister Of Companies
    Número de registro02089582
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Somers Limited
    34 Bermudiana Road
    11 Hamilton Hm 11
    Somers Limited
    Bermuda
    06 abr 2016
    34 Bermudiana Road
    11 Hamilton Hm 11
    Somers Limited
    Bermuda
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroBermuda
    Autoridad legalBermuda Companies Act
    Lugar de registroRegister Of Companies
    Número de registro46441
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene STOCKDALE SECURITIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 17 jul 2013
    Entregado el 02 ago 2013
    Pendiente
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bnp Paribas Securities Services
    Transacciones
    • 02 ago 2013Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 17 jul 2013
    Entregado el 02 ago 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bnp Paribas Securities Services
    Transacciones
    • 02 ago 2013Registro de una carga (MR01)
    Rent deposit deed
    Creado el 25 mar 2013
    Entregado el 27 mar 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest in the account and in the deposit balance. The account means an interest bearing account and the deposit balance means the sum standing to the credit of the account including any accrued interest see image for full details.
    Personas con derecho
    • Pavilion Trustees Limited and Pavilion Property Treustees Limited
    Transacciones
    • 27 mar 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 10 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 ene 2012
    Entregado el 08 feb 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (previously known as arbuthnot securities limited) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 feb 2012Registro de un cargo (MG01)
    Crest security deed
    Creado el 07 ene 2011
    Entregado el 15 ene 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all right, title and interest to or in all money at the date of the security deed or at any time thereafter see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ene 2011Registro de un cargo (MG01)
    Security deed
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as gni financial products limited)to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All sums and payments at the date of the security deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene STOCKDALE SECURITIES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 ene 2021Inicio de la liquidación
    06 sept 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Profesional
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0