STOCKDALE SECURITIES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | STOCKDALE SECURITIES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00762818 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra STOCKDALE SECURITIES LIMITED?
Dirección de la sede social | Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane N12 8LY London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
WESTHOUSE SECURITIES LIMITED | 31 ene 2012 | 31 ene 2012 |
ARBUTHNOT SECURITIES LIMITED | 27 ene 2003 | 27 ene 2003 |
OLD MUTUAL SECURITIES LTD | 11 nov 2002 | 11 nov 2002 |
GNI FINANCIAL PRODUCTS LIMITED | 08 sept 1997 | 08 sept 1997 |
GNI WALLACE LIMITED | 14 may 1986 | 14 may 1986 |
JOHNSON MATTHEY & WALLACE LIMITED | 08 jul 1982 | 08 jul 1982 |
WALLACE BROTHERS COMMODITES LIMITED | 31 may 1963 | 31 may 1963 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STOCKDALE SECURITIES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 14 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 ene 2022 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY a Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane London N12 8LY el 16 feb 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Cassini House 57 st. James's Street London SW1A 1LD England a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY el 27 ene 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 ene 2020 con actualizaciones | 8 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Shore Capital Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Somers Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Beauchamp Proctor el 01 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Clive Black como director el 10 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Finlay Brown como director el 10 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Dru Danford como director el 10 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Crossley como director el 29 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 100 Wood Street London EC2V 7AN England a Cassini House 57 st. James's Street London SW1A 1LD el 12 jul 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2019 au 31 dic 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 12 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Dr Clive Black como director el 31 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Dru Danford como director el 31 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Fine como director el 31 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Alexander Mark Butcher como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Catherine Nash como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 46 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
|
¿Quiénes son los directivos de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCTOR, Andrew Beauchamp | Secretario | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | 219735070001 | |||||||
FINE, Simon | Director | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | England | British | Investment Banker | 257291330001 | ||||
PROCTOR, Andrew Beauchamp | Director | 57 St. James's Street SW1A 1LD London Cassini House England | United Kingdom | British | Finance Director | 171347190001 | ||||
AZIS, Jonathan Giles Ashley | Secretario | Lower Westwood BA15 2AF Bradford On Avon Westwood Manor Wiltshire United Kingdom | 167417280001 | |||||||
BUTLER, Nicola | Secretario | 5th Floor 110 Bishopsgate EC2N 4AY London Heron Tower United Kingdom | 177417540001 | |||||||
FOLEY, Grant Jeffrey | Secretario | Meadowside Road RM14 3YT Upminster 10 Essex United Kingdom | 174154280001 | |||||||
KAYE, Jeremy Robin | Secretario | Mallards 52 Moat Road RH19 3LH East Grinstead West Sussex | British | 9887470001 | ||||||
MAYOR, Sukesh Chander | Secretario | 62 Herbert Road Emerson Park RM11 3LL Hornchurch Essex | British | 72392270001 | ||||||
TELFER, Miranda Lauraine | Secretario | Lingfield House East Grinstead RH7 6ES Lingfield | British | 80083220001 | ||||||
WADE, John Leonard | Secretario | Willow Park RH16 3UA Haywards Heath 15 West Sussex United Kingdom | British | 166249760001 | ||||||
WALLIS, Nicholas Charles | Secretario | 35 Woodstock Road North AL1 4QD St Albans Hertfordshire | British | 4190770001 | ||||||
WOYDA, Jeffrey David | Secretario | Partingdale Manor Partingdale Lane Mill Hill NW7 1NS London | British | 116885950001 | ||||||
AIREY, Christopher Jonathan | Director | Little Newarks Newarks Road Good Easter CM1 4SA Chelmsford Essex | British | Chief Executive | 45740380001 | |||||
ANGEST, Henry, Sir | Director | Thurloe Square SW7 2SR London 40 | England | British | Company Director | 6681230002 | ||||
AZIS, Jonathan Giles Ashley | Director | Lower Westwood BA15 2AF Bradford On Avon Westwood Manor Wiltshire United Kingdom | England | British | Director | 71198840001 | ||||
BISHOP, James Anthony William | Director | 14 Grosvenor Gardens East Sheen SW14 8BY London | United Kingdom | British | Head Of Small Cap Sales | 34341980002 | ||||
BLACK, Clive, Dr | Director | 57 St. James's Street SW1A 1LD London Cassini House England | England | British | Investment Banker | 257295590001 | ||||
BLOMFIELD SMITH, Rosamund Evelyn | Director | 60 Prince Of Wales Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4BH London | England | British | Banker | 79358960001 | ||||
BROWN, Mark Finlay | Director | Wood Street EC2V 7AN London 100 England | England | British | Stock Broker | 198398730001 | ||||
BROWN, Mark Finlay | Director | Holywell House Holywell East Coker BA22 9NQ Yeovil Somerset | England | British | Banker | 98410300001 | ||||
BUTCHER, Alexander Mark | Director | Wood Street EC2V 7AN London 100 England | United Kingdom | British | Non Executive Director | 175730040001 | ||||
BUTLER, Robert Keith | Director | Meadow Way IG7 6LP Chigwell 12 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 26071610002 | ||||
CANWELL, Stuart | Director | Springfield House 22 Springfield Grove TW16 6NT Sunbury On Thames Middlesex | British | Broker | 141825210001 | |||||
COBB, James Robert | Director | 12 The Deerings AL5 2PE Harpenden Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 122932220001 | ||||
CROSSLEY, Andrew John | Director | 57 St. James's Street SW1A 1LD London Cassini House England | England | British | Stockbroker | 106084170001 | ||||
CULL, Graeme Frank | Director | Strathbeg 6 Park Road GU22 7BW Woking Surrey | British | Stockbroker | 62391710001 | |||||
DANFORD, Dru | Director | 57 St. James's Street SW1A 1LD London Cassini House England | England | British | Investment Banker | 257295410001 | ||||
DAVIES, Mark Edward Trehearne | Director | 26 Chester Street SW1X 7BL London | England | British | Commodity Broker | 82536300001 | ||||
DAVIES, Stephen Arthur James | Director | Iverwood 43 Oatlands Chase KT13 9RP Weybridge Surrey | British | Settlements Manager | 73623020001 | |||||
DONALDSON, Nicholas John | Director | 22 St Marys Grove SW13 0JA London | United Kingdom | British | Investment Banker | 29510010002 | ||||
FINLAY, Robert James Dundas | Director | 15 St Botolph Street EC3A 7BB London Beaufort House United Kingdom | United Kingdom | British | Stockbroker | 116483900001 | ||||
FLETCHER, Piers Michael William | Director | Blackberry Farm Winterslow SP5 1QP Salisbury Wiltshire | British | Commodity Broker | 12056130007 | |||||
FOLEY, Grant Jeffrey | Director | Meadowside Road RM14 3YT Upminster 10 Essex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 134335660001 | ||||
FRASER, Craig James, Dr | Director | 20 Ropemaker Street EC2Y 9AR London Arbuthnot House | England | British | Head Of Research | 166816980001 | ||||
GETLEY, Christopher Dewar | Director | Weston NN12 8PU Towcester Hall Farm Northamptonshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 91704460001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STOCKDALE SECURITIES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shore Capital Group Plc | 01 abr 2019 | 57 St. James's Street SW1A 1LD London Cassini House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Somers Limited | 06 abr 2016 | 34 Bermudiana Road 11 Hamilton Hm 11 Somers Limited Bermuda | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene STOCKDALE SECURITIES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 17 jul 2013 Entregado el 02 ago 2013 | Pendiente | ||
Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 17 jul 2013 Entregado el 02 ago 2013 | Pendiente | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 25 mar 2013 Entregado el 27 mar 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The interest in the account and in the deposit balance. The account means an interest bearing account and the deposit balance means the sum standing to the credit of the account including any accrued interest see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 30 ene 2012 Entregado el 08 feb 2012 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (previously known as arbuthnot securities limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Crest security deed | Creado el 07 ene 2011 Entregado el 15 ene 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all right, title and interest to or in all money at the date of the security deed or at any time thereafter see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security deed | Creado el 29 nov 2002 Entregado el 19 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (formerly known as gni financial products limited)to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All sums and payments at the date of the security deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene STOCKDALE SECURITIES LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0