THE HOMARK GROUP LIMITED

THE HOMARK GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE HOMARK GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00763384
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE HOMARK GROUP LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HOMARK ASSOCIATES LIMITED06 jun 196306 jun 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Estado de capital el 15 oct 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    3 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Michael James Kachmer como director el 03 abr 2013

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    8 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Graham Philip Brisley Veal como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Blades como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Prima Secretary Limited el 31 jul 2010

    2 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    10 páginasAA

    Nombramiento de Adrian David Gray como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thomas Doerr como director

    1 páginasTM01

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas190

    legacy

    1 páginas353

    ¿Quiénes son los directivos de THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Tyne And Wear
    Director
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Director
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Director
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Secretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    COOK, Graham Frederick
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    Secretario
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    British56166410001
    ELDRED, Alan Herbert
    20 Broadway Gardens
    PE1 4DU Peterborough
    Cambridgeshire
    Secretario
    20 Broadway Gardens
    PE1 4DU Peterborough
    Cambridgeshire
    British59561230001
    FENTON, Nicola Jane
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    Secretario
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    British31440290005
    HAMPSON, Michael David
    58 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    Secretario
    58 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    British12688630001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Secretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    WAYMAN, Graham Charles
    Rose Cottage
    Newtown, Witchampton
    BH21 5AU Wimborne
    Dorset
    Secretario
    Rose Cottage
    Newtown, Witchampton
    BH21 5AU Wimborne
    Dorset
    British150508280001
    WISEMAN, Julian Richard
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Secretario
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British30890980001
    BELL, Geoffrey Ian
    10 Cellars Farm Road
    BH6 4DL Bournemouth
    Dorset
    Director
    10 Cellars Farm Road
    BH6 4DL Bournemouth
    Dorset
    British56616870001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Director
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    COLDWELL, David John
    Oakleys Farmhouse Maiden Street
    Weston
    SG4 7DQ Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    Oakleys Farmhouse Maiden Street
    Weston
    SG4 7DQ Hitchin
    Hertfordshire
    British48115910001
    COOK, Graham Frederick
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    Director
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    British56166410001
    CORBETT, Robert William
    9 Jupiter Way
    Corfe Mullen
    BH21 3XG Wimborne
    Dorset
    Director
    9 Jupiter Way
    Corfe Mullen
    BH21 3XG Wimborne
    Dorset
    British30890970001
    CRABB, David
    47 Kings Road
    HP4 3BJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    47 Kings Road
    HP4 3BJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish24375840002
    DAVIES, Ieuan
    38b Vicarage Road
    BH31 7DP Verwood
    Dorset
    Director
    38b Vicarage Road
    BH31 7DP Verwood
    Dorset
    British38455660001
    DE ST PAER, Michael John
    Highway Farm
    Great Staughton
    PE19 5BG St. Neots
    Cambridgeshire
    Director
    Highway Farm
    Great Staughton
    PE19 5BG St. Neots
    Cambridgeshire
    British77760720002
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Director
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FAIRHURST, Russell
    137 Colworth Road
    Leytonstone
    E11 1JE London
    Director
    137 Colworth Road
    Leytonstone
    E11 1JE London
    British44556020001
    HARTLEY, Kim
    48 Lulworth Avenue
    Hamworthy
    BH15 4DJ Poole
    Dorset
    Director
    48 Lulworth Avenue
    Hamworthy
    BH15 4DJ Poole
    Dorset
    British35511980001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Director
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Director
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    LEE, Richard John
    The Gables
    Ledbury Road, Eastnor
    HR8 1EL Ledbury
    Herefordshire
    Director
    The Gables
    Ledbury Road, Eastnor
    HR8 1EL Ledbury
    Herefordshire
    British79012830002
    SPENCER, Peter David
    The White House
    Broome Lane Blakedown
    DY10 3LP Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    The White House
    Broome Lane Blakedown
    DY10 3LP Kidderminster
    Worcestershire
    British78077650001
    STEWART, Terence Harry Fitzgibbon
    83 Canford Cliffs Road
    Branksome Park
    BH13 7AH Poole
    Dorset
    Director
    83 Canford Cliffs Road
    Branksome Park
    BH13 7AH Poole
    Dorset
    British24375850002
    WISEMAN, Julian Richard
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Director
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British30890980001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Director corporativo
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    ¿Tiene THE HOMARK GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creado el 11 abr 2002
    Entregado el 25 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 25 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creado el 20 feb 2002
    Entregado el 08 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 08 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creado el 20 nov 2001
    Entregado el 30 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creado el 02 feb 1993
    Entregado el 03 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 30.4.79 (as defined)
    Breve descripción
    Deposit of £22,500 with messrs laytons,st.bartholomews,lewins mead,bristol,BS1 2NH.
    Personas con derecho
    • Matrix (Data Processing) Limited
    Transacciones
    • 03 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 oct 1992
    Entregado el 27 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from the company and homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 43A pottery road parkstone poole dorset BH14 8RB t/n dti 12864.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 19 oct 1992
    Entregado el 21 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 oct 1992
    Entregado el 21 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 29 abr 1983
    Entregado el 18 may 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current
    Breve descripción
    64/64 shares in zerlina ii together with her boats & appurtenances offical no 309988.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 18 may 1983Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 24 abr 1983
    Entregado el 05 may 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the north east side of pattery road poole dorset and/or the proceeds of sale thereof title no at 12864. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1983Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0