GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED

GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00777134
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GREAT GARDENS OF ENGLAND(HOLDINGS) LIMITED11 oct 196311 oct 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A5K27VQ9

    Cese del nombramiento de Justin Matthew King como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01
    X5IV52QI

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015

    8 páginasAA
    A5FWOUQP

    Segunda presentación para la terminación de Nils Olin Steinmeyer como director

    4 páginasRP04TM01
    A5FHC1U8

    Segunda presentación para la terminación de Kevin Michael Bradshaw como director

    4 páginasRP04TM01
    A5FHC2MG

    Nombramiento de Mr Justin Matthew King como director el 18 ago 2016

    2 páginasAP01
    X5E7IAG9

    Cese del nombramiento de Stephen Thomas Murphy como director el 18 ago 2016

    1 páginasTM01
    X5E7IAR4

    Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 22 jul 2016

    2 páginasCH01
    X5DHCEDT

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 may 2016

    Estado de capital el 18 may 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X5786FAP

    Nombramiento de Mr Stephen Thomas Murphy como director el 06 abr 2016

    2 páginasAP01
    X56PSDEH

    Nombramiento de Mr Roger Mclaughlan como director el 10 mar 2016

    2 páginasAP01
    X56N4Y1E

    Cese del nombramiento de Kevin Michael Bradshaw como director el 10 mar 2016

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    22 sept 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016
    X56N5408

    Nombramiento de Mr Anthony Gerald Jones como director el 06 abr 2016

    2 páginasAP01
    X56N53LM

    Cese del nombramiento de Nils Olin Steinmeyer como director el 06 abr 2016

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    22 sept 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016
    X56N54KZ

    Domicilio social registrado cambiado de Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF el 23 feb 2016

    1 páginasAD01
    X51BQ1KO

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014

    8 páginasAA
    A4G8460Q

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 may 2015

    Estado de capital el 22 may 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X47X434R

    Domicilio social registrado cambiado de The Garden Centre Group Syon Park, Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF el 22 may 2015

    1 páginasAD01
    X47X434J

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013

    8 páginasAA
    A3H13UWH

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 may 2014

    Estado de capital el 20 may 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X38A9SMG

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA
    A2GZYTHF

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    X28DUZNV

    Nombramiento de Mr Kevin Michael Bradshaw como director

    2 páginasAP01
    X1N1ZMB6

    ¿Quiénes son los directivos de GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCfo212265950001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    COX, Peter John
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    Secretario
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    British58964650001
    GILBERT, Peter
    27 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    27 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    British24651590001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Secretario
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Secretario
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishChartered Accountant8690590001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Secretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    ALLAN, John Michael
    37 Cavendish Drive
    Claygate
    KT10 0QE Esher
    Surrey
    Director
    37 Cavendish Drive
    Claygate
    KT10 0QE Esher
    Surrey
    BritishDirector17536370001
    ALLETSON, Pamela Daphne
    65 Thorneycroft Close
    KT12 2YB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    65 Thorneycroft Close
    KT12 2YB Walton On Thames
    Surrey
    BritishDirector2389830001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Director
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    BROWN, Leslie
    33 Elderdene
    OX9 4EQ Chinnor
    Oxfordshire
    Director
    33 Elderdene
    OX9 4EQ Chinnor
    Oxfordshire
    BritishDirector24651600001
    CHARLTON, John Fraser
    4 Selwood Place
    SW7 3QQ London
    Director
    4 Selwood Place
    SW7 3QQ London
    BritishDirector17536360001
    COX, Peter John
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    Director
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    BritishFinance Director58964650001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Director
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive107699240001
    HALL, Jonathan Richard
    Pump Cottage
    Pump Lane South Little Marlow
    SL7 3RB Marlow
    Bucks
    Director
    Pump Cottage
    Pump Lane South Little Marlow
    SL7 3RB Marlow
    Bucks
    BritishDirector24651610001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Director
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Director
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park,
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park,
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Director
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park,
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park,
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Directoir1470180001
    MCINTYRE, Duncan Keith
    11 Green Leys
    Church Crookham
    GU13 0PN Fleet
    Hampshire
    Director
    11 Green Leys
    Church Crookham
    GU13 0PN Fleet
    Hampshire
    BritishManaging Director29885580002
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Director
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishChartered Accountant8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChairman207509410001
    OLIVER, Ann Elizabeth
    10 Firs Drive
    Cranford
    TW5 9TD Hounslow
    Middlesex
    Director
    10 Firs Drive
    Cranford
    TW5 9TD Hounslow
    Middlesex
    BritishDirector24651640001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Director
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritishDirector138653690001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Director
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Director
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    RUSSELL, Mark
    18 Thatchers Way
    TW7 7PL Isleworth
    Middlesex
    Director
    18 Thatchers Way
    TW7 7PL Isleworth
    Middlesex
    BritishDirector24651620001
    SMITH, Rosemary Anne
    80 Ouseley Road
    TW19 5JH Wraysbury
    Middx
    Director
    80 Ouseley Road
    TW19 5JH Wraysbury
    Middx
    BritishDirector24651630001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGermanFinancial Director126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Director
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001

    ¿Tiene GREAT GARDENS OF ENGLAND LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 15 ene 1992
    Entregado el 20 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/orthe proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and the benefits of any licences legal mortgage and/or proceeds of sale on palmers nurseries firtree hill chandlers cross herts. T/n hd 92718.land to north east of rousebarn lane chandlers cross sarratt herts. T/n hd 183142 and thames valley garden centre littel marlow bucks.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 feb 1990
    Entregado el 21 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The chandlers cross garden centre fir tree mill, chandlers cross. Title no md 92718 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1990Registro de una carga
    • 05 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0