BRITISH PROPERTY FEDERATION

BRITISH PROPERTY FEDERATION

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRITISH PROPERTY FEDERATION
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 00778293
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    • Actividades de organizaciones de miembros empresariales y de empleadores (94110) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    Dirección de la sede social
    81-87 High Holborn
    WC1V 6DF London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BRITISH PROPERTY FEDERATION LIMITED23 oct 196323 oct 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta30 may 2026
    Próxima declaración de confirmación vence13 jun 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta30 may 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cambio de datos del director Ms Melanie Jane Leech el 01 abr 2026

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Gafar Fashola como director el 01 feb 2026

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 88 Kingsway London WC2B 6AA England a 81-87 High Holborn London WC1V 6DF el 23 ene 2026

    1 páginasAD01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024

    26 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 may 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Alan Jay Leibowitz como director el 14 nov 2024

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de St Albans House 5th Floor 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX a 88 Kingsway London WC2B 6AA el 01 nov 2024

    1 páginasAD01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023

    26 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Josephine Clare Brand como director el 02 jul 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Isabelle Brigitte Hease como director el 02 jul 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Gafar Fashola como director el 02 jul 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Guy John Grainger como director el 02 jul 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Ami Raj Kotecha como director el 04 jul 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon Geoffrey Carter como director el 04 jul 2023

    2 páginasAP01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022

    25 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021

    25 páginasAA

    Cese del nombramiento de William Hughes como director el 05 jul 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Toby Augustine Courtauld como director el 05 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Isabelle Brigitte Hease como director el 01 ene 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Harvin Singh Chohan como director el 01 ene 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020

    25 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Christopher Allan como director el 06 jul 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FLETCHER, Ion Michel Paul
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    Secretario
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    213433920001
    ALLAN, Mark Christopher
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    Director
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    EnglandBritish269336370001
    BRAND, Josephine Clare
    Wigmore Street
    W1U 1PF London
    11/15
    England
    Director
    Wigmore Street
    W1U 1PF London
    11/15
    England
    EnglandBritish131793640001
    CARTER, Simon Geoffrey
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    Director
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    EnglandBritish184444990002
    GORDON, Helen Christine
    c/o Grainger Plc
    London Bridge
    SE1 9BG London
    1
    United Kingdom
    Director
    c/o Grainger Plc
    London Bridge
    SE1 9BG London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish59902650001
    HARDMAN, Jessica Grace
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    Director
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    EnglandBritish271923240001
    KOTECHA, Ami Raj
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    Director
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    EnglandBritish152557680003
    LEECH, Melanie Jane
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    Director
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    EnglandBritish196156470002
    MCDOUGALL, Madeleine Alice
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    Director
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    United KingdomBritish199648970002
    MURPHY, Jonathan Stewart
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    Director
    High Holborn
    WC1V 6DF London
    81-87
    England
    United KingdomBritish121699680002
    PARTRIDGE, David John Gratiaen
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    England
    Director
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    England
    United KingdomBritish41215410026
    BRITTAIN, Anthony Wilkinson
    Stormwell
    Bells Yew Green
    TN3 9AS Tunbridge Wells
    Kent
    Secretario
    Stormwell
    Bells Yew Green
    TN3 9AS Tunbridge Wells
    Kent
    British28611070001
    COSMETATOS, Peter Phocas
    5th Floor
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Secretario
    5th Floor
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    British135309740002
    MCMAHON, Alice Catherine
    833 Lewis Buildings Ixworth Place
    SW3 3QG London
    Secretario
    833 Lewis Buildings Ixworth Place
    SW3 3QG London
    British110073250001
    OGWEZI, Theodora
    Boscombe Avenue
    RM17 6DU Grays
    44
    Essex
    U:K
    Secretario
    Boscombe Avenue
    RM17 6DU Grays
    44
    Essex
    U:K
    British128709810001
    PANTING, Andrew Davidson
    c/o British Property Federation, 5th Floor
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    57-59
    England
    Secretario
    c/o British Property Federation, 5th Floor
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    57-59
    England
    181065770001
    WILSON, Derek Robert
    The Spinney Misbourne Avenue
    Chalfont St Peter
    SL9 0PF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    The Spinney Misbourne Avenue
    Chalfont St Peter
    SL9 0PF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British34786640001
    ADAMS, Aubrey John
    Kidmore End
    RG4 9AP Reading
    Vines Farm
    United Kingdom
    Director
    Kidmore End
    RG4 9AP Reading
    Vines Farm
    United Kingdom
    EnglandBritish10219610001
    ALDRIDGE, Roger
    The Orchard 33 Harcourt Road
    Dorney Reach
    SL6 0DT Maidenhead
    Berkshire
    Director
    The Orchard 33 Harcourt Road
    Dorney Reach
    SL6 0DT Maidenhead
    Berkshire
    British34584530001
    ALLEN, Peter Kenneth
    88 Cremorne Road
    Cremorne
    Sydney
    New South Wales 2090
    Australia
    Director
    88 Cremorne Road
    Cremorne
    Sydney
    New South Wales 2090
    Australia
    British69229480002
    ANDERSON, Randolph John
    43 Duckett Road
    N4 1BJ London
    Director
    43 Duckett Road
    N4 1BJ London
    British65745670001
    ARMON-JONES, Christopher Hamilton
    11a Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    Director
    11a Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    British4182110001
    ASHLEY BROWN, Michael
    Stella Lodge 2 Camp Hill
    Waverley
    GU10 1RJ Farnham
    Surrey
    Director
    Stella Lodge 2 Camp Hill
    Waverley
    GU10 1RJ Farnham
    Surrey
    British75552330004
    AXTON, Henry Stuart
    Hook Place Hook Lane
    Aldingbourne
    PO20 6TS Chichester
    West Sussex
    Director
    Hook Place Hook Lane
    Aldingbourne
    PO20 6TS Chichester
    West Sussex
    British12130300001
    BALDRY, Lorraine Ingrid
    6 Bingham Street
    Islington
    N1 2QQ London
    Director
    6 Bingham Street
    Islington
    N1 2QQ London
    United KingdomBritish75761630001
    BARBER, Martin
    Penthouse G Saint Johns Wood Court
    Saint Johns Wood Road
    NW8 8QT London
    Director
    Penthouse G Saint Johns Wood Court
    Saint Johns Wood Road
    NW8 8QT London
    British35534320003
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Director
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritish38758710002
    BELLHOUSE, Christopher Edward
    Merrie Oak
    Warmlake Sutton Valence
    ME17 3JA Maidstone
    Kent
    Director
    Merrie Oak
    Warmlake Sutton Valence
    ME17 3JA Maidstone
    Kent
    EnglandBritish15552970001
    BRIGHT, Roger Martin Francis
    52 Ridgway Road
    GU9 8NS Farnham
    Surrey
    Director
    52 Ridgway Road
    GU9 8NS Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish79382840001
    BROADHURST, Robin Shedden
    13 Lansdowne Crescent
    W11 2NJ London
    Director
    13 Lansdowne Crescent
    W11 2NJ London
    United KingdomBritish20089560002
    BROWN, Nigel Anthony
    Fosse Lodge
    138 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Director
    Fosse Lodge
    138 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    British68890990001
    BRUNDAGE, Paul Arthur
    New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    6
    England
    Director
    New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    6
    England
    EnglandCanadian197996860001
    BURNS, John David
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    Director
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    United KingdomBritish9820610002
    BUTTERWORTH, Mark Stephen
    Moorfield Lodge
    145 Lapwing Lane
    M20 6US Didsbury
    Manchester
    Director
    Moorfield Lodge
    145 Lapwing Lane
    M20 6US Didsbury
    Manchester
    EnglandBritish53843340004
    CALVERLEY, David
    Four Winds House
    Pitch Hill Ewhurst
    GU6 7NL Cranleigh
    Surrey
    Director
    Four Winds House
    Pitch Hill Ewhurst
    GU6 7NL Cranleigh
    Surrey
    British4527360001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BRITISH PROPERTY FEDERATION?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    30 may 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0