HAVELOCK EUROPA PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHAVELOCK EUROPA PLC
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 00782546
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HAVELOCK EUROPA PLC?

    • Fabricación de muebles de oficina y tienda (31010) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra HAVELOCK EUROPA PLC?

    Dirección de la sede social
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HAVELOCK EUROPA PLC?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2018
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2019
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HAVELOCK EUROPA PLC?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta20 jun 2019
    Próxima declaración de confirmación vence04 jul 2019
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta20 jun 2018
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HAVELOCK EUROPA PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    25 páginasAM23

    Informe de progreso del administrador

    21 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    21 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    22 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    24 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    25 páginasAM10

    Declaración de la propuesta del administrador

    32 páginasAM03

    Domicilio social registrado cambiado de I2 Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park Mansfield Nottinghamshire NG18 5FB a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 26 sept 2018

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA

    31 páginasAM02

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2017

    71 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Hakeem Oluwatosin Yesufu como director el 18 mar 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Donald William Borland como director el 06 abr 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Bruce Middleton como secretario el 06 abr 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Donald William Borland como secretario el 06 abr 2018

    1 páginasTM02

    Registro de la carga 007825460008, creada el 02 mar 2018

    25 páginasMR01

    Registro de la carga 007825460007, creada el 08 mar 2018

    7 páginasMR01

    Nombramiento de Mr Shaun Allen Ormrod como director el 27 sept 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David John Alexander Ritchie como director el 26 sept 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de HAVELOCK EUROPA PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MIDDLETON, Bruce
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Secretario
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    245012540001
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    ScotlandBritishCompany Director132405720006
    GODDEN, Ian Adam
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United Arab EmiratesBritishChairman223235130001
    ORMROD, Shaun Allen
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritishChief Executive238467880001
    SWEETMAN, Richard John
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    ScotlandBritishCompanydirector123777750001
    YESUFU, Hakeem Oluwatosin
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    CanadaNigerianNon-Executive Director247751120001
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Secretario
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    230319390001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    BritishAccountant65759080002
    GRAY, Alexander Duncan
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    British187835130001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Secretario
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    188761690001
    MACSPORRAN, Graham
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    Secretario
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    BritishAccountant71376370001
    SMITH, Eric Macdonald
    21 Buchanan Drive
    G61 2EW Glasgow
    Secretario
    21 Buchanan Drive
    G61 2EW Glasgow
    British76035570001
    WEBSTER, John Strachan
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    British718070001
    ASLET, Peter Michael
    Burnbrae Horsewood Road
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Director
    Burnbrae Horsewood Road
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    BritishFinancial Executive73615130003
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    Director
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    United KingdomBritishCompany Director132405720001
    BELL, Simon Leonard Lawrance
    16 Coleherne Mews
    SW10 9EA London
    Director
    16 Coleherne Mews
    SW10 9EA London
    BritishAccountant31486540002
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant66010670002
    BUDDEN, John Michael
    29 Six Hills Road
    Walton Le Wolds
    LE12 8JF Loughborough
    Leicestershire
    Director
    29 Six Hills Road
    Walton Le Wolds
    LE12 8JF Loughborough
    Leicestershire
    BritishDirector22057580001
    BURGESS, Andrew Elliott
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    FranceBritishCompany Director184199220001
    DERBYSHIRE, Michael Joseph Christian
    The Hill
    Whitmore
    ST5 5HU Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    The Hill
    Whitmore
    ST5 5HU Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director11458180003
    DILLON, Peter Marshall
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director201559530001
    DUNCAN, Robert Alexander
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    Director
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    BritishAccountant48510002
    FAIRWEATHER, James Henry Whitton
    The Hoolets Yett
    Pencaitland
    EH34 5EY Tranent
    East Lothian
    Director
    The Hoolets Yett
    Pencaitland
    EH34 5EY Tranent
    East Lothian
    United KingdomBritishPersonnel Director693160001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishAccountant65759080002
    GODDEN, Ian Adam
    9 Drax Avenue
    SW20 0EG London
    Director
    9 Drax Avenue
    SW20 0EG London
    United KingdomBritishManagement Consultant35852610002
    GOURLAY, John Malcolm
    57 Dick Place
    EH9 2JA Edinburgh
    Director
    57 Dick Place
    EH9 2JA Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director574590003
    HAMILL, Ronald Gordon
    Cavendish House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Director
    Cavendish House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director116784830001
    HURCOMB, David Stuart
    Moss Way
    Hillend Industrial Estate
    KY11 9JS Dalgety Bay
    Havelock Europa Plc
    Fife
    Director
    Moss Way
    Hillend Industrial Estate
    KY11 9JS Dalgety Bay
    Havelock Europa Plc
    Fife
    United KingdomBritishCeo34516340004
    JEMMETT-PAGE, Shonaid Christina Ross
    Adams Lane
    Northiam
    TN31 6JR Rye
    Spanyards Farm
    East Sussex
    Director
    Adams Lane
    Northiam
    TN31 6JR Rye
    Spanyards Farm
    East Sussex
    United KingdomBritishNone133875880001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    ScotlandIrishFinance Director43853920002
    KENNEDY, William Michael Clifford
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    Director
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    BritishCompany Director295080001
    KERR, Alastair Gibson
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director124295480001
    LESSELS, Norman
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    Director
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    BritishChartered Accountant681350002
    LONGWORTH, Edward Nicholas
    23 Tennent Park
    Mid Calder
    EH53 0RF Livingston
    West Lothian
    Director
    23 Tennent Park
    Mid Calder
    EH53 0RF Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritishDirector22057570001
    LOWERY, Richard
    93 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SE Norwich
    Norfolk
    Director
    93 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishCompany Director4842970001

    ¿Tiene HAVELOCK EUROPA PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 08 mar 2018
    Entregado el 09 mar 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    All and whole the subjects on the south side of mitchelston drive, kirkcaldy, registered in the land register of scotland under title number FFE93583.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 02 mar 2018
    Entregado el 14 mar 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    All property charged under clause 3.1 of the charge, including:. (1) by way of legal mortgage all estates or interests in the freehold and leasehold property described in the schedule to the charge, together with all present and future buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures), which are at any time on or attached to the property; and. (2) by way of fixed charge: (I) all estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to the company now or at any time after the date of the charge (other than any property charged in terms of (1) above) together with all buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures) which are at any time on or attached to the property; (ii) all present and future interests of the company in or over land or the proceeds of sale of it and all present and future licences of the company to enter upon or use land; (iii) the benefit of all other agreements relating to land which the company is or may become party to or otherwise entitled; (iv) all patents, utility models, registered and unregistered trade and service marks, rights in passing off, copyright, registered and unregistered rights in designs and database rights in each case now or in the future held by the company (whether alone or jointly with others) anywhere in the world and including any extensions and renewals of, and any application for such rights; (v) the benefit of all agreements and licences now or in the future entered into or enjoyed by the company relating to the use or exploitation by or on behalf of the company in any part of the world of any such rights as are referred to in (iv) above but owned by others; (vi) all the company's rights now or in the future in relation to trade secrets, confidential information and know how in any part of the world.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Scottish Enterprise
    Transacciones
    • 14 mar 2018Registro de una carga (MR01)
    Debenture
    Creado el 28 abr 2010
    Entregado el 07 may 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    Rent deposit deed
    Creado el 12 abr 2002
    Entregado el 25 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The tenant charges with full title guarantee its interest in the deposit account with payment of the liabilities.
    Personas con derecho
    • Co-Operative Group (Cws) Limited
    Transacciones
    • 25 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 28 ago 1998
    Entregado el 08 sept 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land on the south side of bailey grove road eastwood parish t/n NT75472 nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 sept 1998Registro de un cargo (395)
    Deed of substitution
    Creado el 07 feb 1991
    Entregado el 09 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £360,000 and further advances
    Breve descripción
    Land at bailey grove road, eastwood nottinghamshire title no. Nt 75472.
    Personas con derecho
    • London and Manchester (Commercial Mortgages) Limited
    Transacciones
    • 09 feb 1991Registro de una carga
    • 22 may 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First legal charge
    Creado el 25 abr 1988
    Entregado el 28 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £400,000 and further advances due from the company to the chargee.
    Breve descripción
    37, marylebourne lane, london W1.
    Personas con derecho
    • London and Manchester (Commercial Mortgages) Limited
    Transacciones
    • 28 abr 1988Registro de una carga
    • 03 dic 1992Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 22 may 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 21/1/86
    Creado el 21 ene 1986
    Entregado el 07 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Block 1 barnsford road inchinnan industrial estate, inchinnan, renfrew PA4 9RE.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 07 feb 1986Registro de una carga
    • 02 mar 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene HAVELOCK EUROPA PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 jul 2021Fin de la administración
    03 jul 2018Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Graham Douglas Frost
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Profesional
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0