PAYLESS DIY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPAYLESS DIY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00783953
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PAYLESS DIY LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra PAYLESS DIY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Greater Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PAYLESS DIY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    W.H. SMITH DO IT ALL LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    L.C.P. HOME IMPROVEMENTS LIMITED09 dic 196309 dic 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PAYLESS DIY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta21 feb 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAYLESS DIY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 01 may 2012

    27 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 04 nov 2011

    38 páginas2.24B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    96 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    95 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B/2.15B

    9 páginas2.16B

    Cambio de datos del director Mr William Grimsey el 13 may 2011

    3 páginasCH01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Domicilio social registrado cambiado de Gawsworth House Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6XB el 11 may 2011

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Brian Robbins como director

    2 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Dawn Michelle Wilkinson el 11 oct 2010

    3 páginasCH03

    Cambio de datos del director Thomas Christopher Morgan el 11 oct 2010

    3 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Richard Bird como director

    2 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Robert Patrick Gladwin el 11 oct 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Brian Keith Robbins el 11 oct 2010

    3 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 21 feb 2010

    7 páginasAA

    Nombramiento de Brian Keith Robbins como director

    3 páginasAP01

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 03 jun 2010

    2 páginas1.3

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    2 páginas1.4

    Nombramiento de Thomas Christopher Morgan como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Unitt como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PAYLESS DIY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILKINSON, Dawn Michelle
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United Kingdom
    British105435010001
    GLADWIN, Robert Patrick
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Director
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish130288970001
    GRIMSEY, William
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    Director
    9 The Avenue
    WD7 7DG Radlett
    Tall Timbers
    Hertfordshire
    United KingdomBritish50647840004
    MORGAN, Thomas Christopher
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Director
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomBritish152428250002
    FENNELL, Sonia
    Gilliver Cottage Gilliver Lane
    Clipston On The Wolds
    NG12 5PD Nottingham
    Secretario
    Gilliver Cottage Gilliver Lane
    Clipston On The Wolds
    NG12 5PD Nottingham
    British9591230004
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    HUGHES, Gerard Maxwell
    53 Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    Secretario
    53 Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    British70698270002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STEVENS, Philip Alan
    31 Summit Drive
    IG8 8QW Woodford Green
    Essex
    Secretario
    31 Summit Drive
    IG8 8QW Woodford Green
    Essex
    British9581300001
    WILLIAMS, David Robert
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    Secretario
    15 St Stephens Road
    CH42 8PP Prenton
    Merseyside
    British157062220001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secretario
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001
    ACKROYD, Keith
    32 Far Street
    Bradmore
    NG11 6PF Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    32 Far Street
    Bradmore
    NG11 6PF Nottingham
    Nottinghamshire
    British9261020001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Director
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BIRD, Richard Sidney
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    Director
    80 Wolsey Road
    HA6 2EH Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish111500210002
    BOWE, Alan Laurence
    Church View Farmhouse
    Church Lane, Osgathorpe
    LE12 9SY Loughborough
    Leicestershire
    Director
    Church View Farmhouse
    Church Lane, Osgathorpe
    LE12 9SY Loughborough
    Leicestershire
    British64241650002
    COHEN, John Alexander
    7 Rectory Gardens
    Wollaton
    NG8 2AR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    7 Rectory Gardens
    Wollaton
    NG8 2AR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish25406220001
    FIELD, Malcolm, Sir
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    Director
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    British74857040001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    3 Cottage Farm Close
    Osgathorpe
    LE12 9UE Loughborough
    Leicestershire
    Director
    3 Cottage Farm Close
    Osgathorpe
    LE12 9UE Loughborough
    Leicestershire
    British52040210002
    FURNISS, Ronald William
    30 Marlock Close
    Fiskerton
    NG25 0UB Southwell
    Nottinghamshire
    Director
    30 Marlock Close
    Fiskerton
    NG25 0UB Southwell
    Nottinghamshire
    British24556400001
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Director
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    HOOD, John
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    Director
    Briarwood
    15 Twatling Road Barnt Green
    B45 8HX Birmingham
    West Midlands
    British39644740001
    HOSKINS, William
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    11 Grange Court Road
    AL5 1BY Harpenden
    Hertfordshire
    British121893830001
    JOHNSON, Stephen Richard
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    Director
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    EnglandBritish87398750001
    KIDD, Geoffrey David
    Orchard House Grey Green Lane
    Wribbenhall
    DY12 1LT Bewdley
    Worcestershire
    Director
    Orchard House Grey Green Lane
    Wribbenhall
    DY12 1LT Bewdley
    Worcestershire
    British21889890002
    MCDOUGAL, Robert Hugh
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    Director
    41 Tensing Close Great Sankey
    WA5 5AN Warrington
    Cheshire
    British15170390002
    MORTON, Ivor Malcolm
    Lysander
    8 Pine Close Shottery
    CV37 9FB Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Director
    Lysander
    8 Pine Close Shottery
    CV37 9FB Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British30725390003
    MURRAY, Stephan Peter
    Red Brick Barn
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Red Brick Barn
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    British53490630001
    NAPIER, John Alexander
    Rocks Stud Farm
    Brantridge Lane
    RH17 6JR Balcombe
    West Sussex
    Director
    Rocks Stud Farm
    Brantridge Lane
    RH17 6JR Balcombe
    West Sussex
    British14311010002
    PIGGOTT, Kenneth Stanton
    172 Loughborough Road
    NG11 6LF Ruddington
    Nottingham
    Director
    172 Loughborough Road
    NG11 6LF Ruddington
    Nottingham
    United KingdomBritish144061950001
    RADFORD, Kenneth Thomas
    21 Melton Road
    Tollerton
    NG12 4EL Nottingham
    Director
    21 Melton Road
    Tollerton
    NG12 4EL Nottingham
    British47191400001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Director
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    ROBBINS, Brian Keith
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    Director
    Westmere Drive
    CW1 6XB Crewe
    Gawsworth House
    Cheshire
    United KingdomAmerican153559370002
    RUSSELL, Stephen George
    The Manor Barn
    19b Far Street Wymeswold
    LE12 6TZ Loughborough
    Leicestershire
    Director
    The Manor Barn
    19b Far Street Wymeswold
    LE12 6TZ Loughborough
    Leicestershire
    British145267530001
    SCRIBBINS, Rodney Martin
    The Hemploe
    Hemploe Road
    NN6 6HF Welford
    Northampton
    Director
    The Hemploe
    Hemploe Road
    NN6 6HF Welford
    Northampton
    EnglandBritish98160250001
    SINCLAIR, Jonathan Stuart
    57 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Director
    57 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    British45080280003

    ¿Tiene PAYLESS DIY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security accession deed
    Creado el 22 feb 2007
    Entregado el 06 mar 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    Transacciones
    • 06 mar 2007Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 19 ago 1998
    Entregado el 03 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter
    Breve descripción
    F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PAYLESS DIY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 ago 2009Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    03 jun 2010Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    FechaTipo
    01 may 2012Fin de la administración
    05 may 2011Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Profesional
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Profesional
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Michael Hudson
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0