OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00785105 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 7 Barton Close LE19 1SJ Leicester United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | 14 may 1987 | 14 may 1987 |
| SIKORSKY HOLDINGS (UK) PLC | 09 dic 1985 | 09 dic 1985 |
| CARICOR HOLDINGS LIMITED | 18 dic 1963 | 18 dic 1963 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 nov 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 ago 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de 10th Floor Vantage Great West Road Brentford TW8 9AG England a 7 Barton Close Leicester LE19 1SJ el 18 mar 2026 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mrs Vanessa Ann King-Clarke como director el 14 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Ales Korotvicka como director el 14 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Bjoern Molzahn como director el 13 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Carlos Arango como director el 31 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2024 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2023 | 27 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Jason Caulfield como director el 02 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2022 | 27 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2020 | 28 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Robert William Sadler el 05 sept 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Bjoern Molzahn el 05 sept 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Jason Caulfield el 05 sept 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Carlos Arango el 05 sept 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2021 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Chiswick Park Building 5, Ground Floor 566 Chiswick High Road London W4 5YF England a 10th Floor Vantage Great West Road Brentford TW8 9AG el 02 jul 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2019 | 33 páginas | AA | ||
legacy | 5 páginas | SH20 | ||
Estado de capital el 02 dic 2020
| 3 páginas | SH19 | ||
legacy | 5 páginas | CAP-SS | ||
¿Quiénes son los directivos de OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN COE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Stone Buildings WC2A 3TH London 2 England |
| 98679750001 | ||||||||||
| KING-CLARKE, Vanessa Ann | Director | Barton Close LE19 1SJ Leicester 7 United Kingdom | England | British | 283638370001 | |||||||||
| KOROTVICKA, Ales | Director | Barton Close LE19 1SJ Leicester 7 United Kingdom | England | Czech | 343119420001 | |||||||||
| SADLER, Robert William | Director | Barton Close LE19 1SJ Leicester 7 United Kingdom | England | British | 107127030002 | |||||||||
| BANIS, Lynn | Secretario | Littleton Road TW15 1TZ Ashford 1st Floor Ash House Middlesex | British | 167821800001 | ||||||||||
| BOOKER, Roger Denys | Secretario | Church Fields Rotherfield Greys RG9 4QE Henley On Thames Oxfordshire | British | 84244630001 | ||||||||||
| CALVO, Susana | Secretario | East 96th Street Apartment 25 N New York 175 Ny 10128 United States | British | 111962610002 | ||||||||||
| CRIMMINS, Eileen Marie | Secretario | 3 Grey Fox Trail Avon CT 06001 Hartford County Connecticut Usa | Usa | 31317660001 | ||||||||||
| CUST, Gary William | Secretario | Kidmore Road Caversham RG4 7LU Reading 27 Berkshire | British | 193071220001 | ||||||||||
| FINGER, Shelley | Secretario | 8302 Town Walk Drive Hamden Ct 06518 United States Of America | British | 99519650001 | ||||||||||
| HILDEBRAND, Charles | Secretario | 65 Pierce Boulevard CT06095 Windsor America | American | 71790520001 | ||||||||||
| OGDEN, Alan James | Secretario | 7 Havecock Road Croydon Surrey | British | 6669890001 | ||||||||||
| PENTEADO RODRIGUES, Terena | Secretario | 19 Lexington Road West Hartford Connecticut 06119-1748 Usa | British | 92079080001 | ||||||||||
| RUA, Christine | Secretario | 254 Olde Stage Road Glastonbury Connecticut 06033 Usa | American | 71920570001 | ||||||||||
| SMITH, Allison | Secretario | 12 Granger Circle East Granby 06026 Connecticut Usa | Usa | 59654800001 | ||||||||||
| USCILLA, Paula-Marie | Secretario | Atwater Street Milford 59 Connecticut 06460 Usa | British | 137979680001 | ||||||||||
| VITRANO, Nicole | Secretario | Poyle Road SL3 0HB Colnbrook Mathisen Way Berkshire | British | 148250290001 | ||||||||||
| ARANGO, Carlos | Director | Vantage Great West Road TW8 9AG Brentford 10th Floor England | England | British | 266374700001 | |||||||||
| BOTTOMLEY, Stuart | Director | Huskisson Way Stratford Road B90 4SS Shirley Fore 1 Fore Business Park Solihull United Kingdom | England | British | 193421620001 | |||||||||
| CAINE, Franklyn A | Director | 44 Sycamore Road West Hartford Connecticut Usa | American | 68402000001 | ||||||||||
| CAULFIELD, Jason | Director | Vantage Great West Road TW8 9AG Brentford 10th Floor England | United Kingdom | Irish | 266374970001 | |||||||||
| CORAN, Mark Stephen | Director | 23 Quail Hollow FOREIGN West Hartford Connecticut 06117 Usa | American | 10309450001 | ||||||||||
| CUST, Gary William | Director | Kidmore Road Caversham RG4 7LU Reading 27 Berkshire | England | British | 193071220001 | |||||||||
| DARNIS, Geraud | Director | 5 Carlton Mansions W14 8DW London | French | 23537510001 | ||||||||||
| FLYNN JR, Frederick Collins | Director | 496 Town Street FOREIGN East Haddam Connecticut 06423 Usa | American | 10309470001 | ||||||||||
| HAMBLY, Michael John Charles | Director | 54 Highlands Heath Putney SW15 3TX London | British | 27606950001 | ||||||||||
| HAMILTON, Peter Boris | Director | 31 Chantry View Road GU1 3XW Guildford Surrey | British | 5815740001 | ||||||||||
| IDCZAK, Christian Bruno Jean | Director | Huskinsson Way Stratford Road B90 4SS Shirley Fore 1 Fore Business Park Solihull United Kingdom | England | French | 192320890001 | |||||||||
| KULLAR, Rajinder Singh | Director | Poyle Road SL3 0HB Colnbrook Mathisen Way Berkshire | Untied Kingdom | British | 74999290008 | |||||||||
| KUMAR, Puthcode Lakshmi Narayanan Arun | Director | 15-18 Rue De Pontoise St Germain En Laye France | Indian | 55553760001 | ||||||||||
| LAURENCE, James Terence George | Director | Croft Road LE9 1SE Colby 74 Leicestershire | United Kingdom | British | 122206950001 | |||||||||
| LEINGANG, John Thomas | Director | 15 Barham Road Wimbledon SW20 0EX London | American | 10309420001 | ||||||||||
| MACKIEWICZ, Susan | Director | 16 Rue Du Bourg Tibourg FOREIGN 75004 Paris France | American | 61846470001 | ||||||||||
| MACNAUGHTON, Kenneth Andrew | Director | 2a West Hill Road SW18 1LN London | United Kingdom | British | 55299990002 | |||||||||
| MICHAUD DANIEL, Didier | Director | 18 Woodville Road W5 2SF London | French | 78888250003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de OTIS ELEVATOR HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otis Worldwide Corporation | 03 abr 2020 | Farm Springs Road Farmington 10 Connecticut, Ct 06032 United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| United Technologies Corporation | 13 ago 2019 | Orange Street The Corporation Trust Company DE19801 Corporation Trust Center, Wilmington 129 Delaware United States | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Goodrich Aftermarket Services Limited | 06 abr 2016 | Colnbrook SL3 0HB Slough Mathisen Way United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0