MW (OLDCO) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MW (OLDCO) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00785935 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MW (OLDCO) LIMITED?
- fabricación de pinturas, barnices y recubrimientos similares, mastiques y selladores (20301) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra MW (OLDCO) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MW (OLDCO) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MORRELLS WOODFINISHES LIMITED | 06 jun 1996 | 06 jun 1996 |
| F.T. MORRELL & CO LIMITED | 24 dic 1963 | 24 dic 1963 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MW (OLDCO) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 may 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MW (OLDCO) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital el 25 abr 2022
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des détails de Morrells Woodfinishes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Hays Galleria 1 Hays Lane London SE1 2rd a 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX el 30 jul 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2020 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de F T Morrwll & Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 feb 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Johnny W. Green Jr como director el 28 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lesley Philippa Bridgwater como director el 28 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Stuart O'connor como director el 28 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2019 | 34 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen James Knoop como director el 15 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2018 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MW (OLDCO) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAYTON, Scott Geoffrey Cameron | Director | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | England | British | 64518310003 | |||||
| GREEN JR, Johnny W. | Director | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | United States | American | 269441510001 | |||||
| HOLMAN, Ronnie Gene | Director | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | United States | American | 197026090001 | |||||
| BRIDGWATER, Lesley Philippa | Secretario | St. Margarets Street CT1 2TU Canterbury 37 Kent England | 148880010001 | |||||||
| MORRELL, Graham | Secretario | 24 Davenport Park Road SK2 6JS Stockport Cheshire | British | 39067760002 | ||||||
| MORRELL, Peter Henry | Secretario | 5 Tollgate Close Bromham MK43 8QN Bedford Bedfordshire | British | 12082820001 | ||||||
| PRIOR, Michael John | Secretario | 9 Gaddum Road Bowdon WA14 3PD Altrincham Cheshire | British | 69677460003 | ||||||
| BOYLE, Alexander Stewart | Director | 5 Forge Close Kirklington NG22 8GZ Newark Nottinghamshire | British | 1106110003 | ||||||
| BRANDON, Robin Nichol | Director | High Field Woodhouse End Road, Gawsworth SK11 9QS Macclesfield Cheshire | British | 66402440001 | ||||||
| BRIDGWATER, Lesley Philippa | Director | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | England | British | 95186950001 | |||||
| CAMPBELL, Anthony Reginald | Director | Manor Farm Barn Little Hadham SG11 2DD Bishops Stortford Herts | United Kingdom | British | 127223200001 | |||||
| CHURCHMAN, Anthony | Director | 13a Eastfield Road SG8 7ED Royston Hertfordshire | British | 48018980001 | ||||||
| FYNN, Jeremy Martin Newnham | Director | 7 Richmond Road Heaton Hersey SK4 3BZ Stockport Cheshire | England | British | 98086980001 | |||||
| KNOOP, Stephen James | Director | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 197026110001 | |||||
| MOORE, Edward Winslow | Director | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 151290070001 | |||||
| MORRELL, Graham | Director | 24 Davenport Park Road SK2 6JS Stockport Cheshire | British | 39067760002 | ||||||
| MORRELL, Joseph Bertram | Director | 15 Chipperfield Road WD4 9JB Kings Langley Herts | England | British | 12082830001 | |||||
| MORRELL, Peter Henry | Director | 5 Tollgate Close Bromham MK43 8QN Bedford Bedfordshire | British | 12082820001 | ||||||
| O'CONNOR, Anthony Stuart | Director | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United Kingdom | British | 71023900003 | |||||
| POOLEY, John | Director | 5 Hampshire Close SK13 8SA Glossop Derbyshire | British | 66402360001 | ||||||
| RICE, Ronald Albert | Director | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 115014650001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MW (OLDCO) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrells Woodfinishes Limited | 06 abr 2016 | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MW (OLDCO) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 04 ago 2017 Entregado el 04 ago 2017 | Pendiente | ||
Breve descripción None. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 may 2010 Entregado el 28 may 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 ene 2002 Entregado el 05 ene 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 15 feb 2001 Entregado el 07 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 19 dic 2000 Entregado el 08 ene 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 13 mar 1997 Entregado el 18 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 jul 1994 Entregado el 29 jul 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Wood house (formerly alban court) being part of brownfields welwyn garden city t/n HD232337. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 01 dic 1993 Entregado el 14 dic 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Botany mill and land lying north of woodlands drive woodley greater manchester title no GM107143. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 ene 1989 Entregado el 09 feb 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 212 acton lane l/b of brent title no ngl 458972. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 dic 1977 Entregado el 20 dic 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 214 acton lane, harlesden, brent, london, nw 10 as comprised in a lease dated 11.11.76. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0