ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00787507 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED?
- Investigación de mercados y encuestas de opinión pública (73200) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pembroke Building Avonmore Road W14 8DG London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALBEMARLE YANKELOVICH CLANCY SHULMAN LIMITED | 15 sept 1989 | 15 sept 1989 |
| ALBEMARLE MARKET RESEARCH LIMITED | 09 ene 1964 | 09 ene 1964 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Nicola Raj como secretario el 07 jun 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Magnus Djaba Djaba como director el 31 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard James Hytner como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Justin Kenneth Billingsley como director el 31 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Sophie Marie Cassandre Martin-Chantepie como director el 31 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alex Bekkerman como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Senior como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Raj Basran como secretario el 18 ene 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Richard James Hytner como director el 19 nov 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Annabelle Jane Spooner como director el 19 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Harker como director el 03 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alex Bekkerman como director el 26 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Joanne Munis como secretario el 07 abr 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Anne Bailey como secretario el 02 abr 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Pembroke Building Avonmore Road London W14 8DG a Pembroke Building Avonmore Road London W14 8DG el 08 abr 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 19 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNIS, Joanne | Secretario | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | 196628860001 | |||||||
| RAJ, Nicola | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building United Kingdom | 233357770001 | |||||||
| BILLINGSLEY, Justin Kenneth | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | England | Australian | 228671340001 | |||||
| DJABA, Magnus Djaba | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | England | British | 174454590001 | |||||
| MARTIN-CHANTEPIE, Sophie Marie Cassandre | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | France | French | 228671040001 | |||||
| BAILEY, Sarah Anne | Secretario | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | 185048620001 | |||||||
| BASRAN, Raj | Secretario | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | 169960300001 | |||||||
| DAVIS, Robert | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | British | 155457840001 | ||||||
| EARL, Elizabeth Louise Kiernan | Secretario | 9 Helena Road SL4 1JN Windsor Berkshire | British | 105197540001 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secretario | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| EWING, Susanna | Secretario | 72f Sinclair Road W14 0NJ London | British | 122102410001 | ||||||
| GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katariina | Secretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | Finnish | 119965730001 | ||||||
| JANS, Annamaria | Secretario | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||
| KURTZ, Catherine Elizabeth Strathmore | Secretario | 6 Berkeley Road TN1 1YR Tunbridge Wells Kent | British | 54236170003 | ||||||
| WALLS ECKLEY, Gillian | Secretario | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | 160040580001 | |||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Secretario | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| WYLLIE, Alison | Secretario | Flat 2 186 Ladbroke Grove W10 5LZ London | British | 107811220001 | ||||||
| BEKKERMAN, Alex | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | England | American | 198886380001 | |||||
| CHAPMAN, Aidan Gerard | Director | 74 Marshalswick Lane AL1 4XE St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 51799970001 | |||||
| COURET, Philippe Francois Pierre | Director | Flat 9 1 Prince Of Wales Terrace W8 5PG London | French | 68861790003 | ||||||
| EVANS, Fiona Maria | Director | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||
| GRAHAM, Alec | Director | Linden Lea, Packhorse Road Bessels Green TN13 2QP Sevenoaks Kent | British | 73621260001 | ||||||
| HARKER, Alan | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | England | British | 174823410001 | |||||
| HYTNER, Richard James | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke | United Kingdom | British | 49370650001 | |||||
| LOWE, Richard | Director | 3 Dukes Avenue N10 2PS London | British | 26494230001 | ||||||
| LUCAS, Martin George | Director | 12 Stavordale Road N5 1NE London | England | British | 61451430002 | |||||
| RANFORD, Paul Frederick | Director | Bacombe Beeches 89 Ellesborough Road Wendover HP22 6ES Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 35512360002 | |||||
| REBELO, Michael | Director | Charlotte Street W1A 1AQ London 80 England | England | Australian | 133812720001 | |||||
| SENIOR, Robert William | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | England | British | 178019870001 | |||||
| SPOONER, Annabelle Jane | Director | Building Avonmore Road W14 8DG London Pembroke England | England | British | 127871790001 | |||||
| SPOONER, Annabelle Jane | Director | 14 Vanbrugh Hill Blackheath SE3 7UF London | British | 26494240001 | ||||||
| WATSON, Robert Drummond | Director | 2 Whybourne Crest TN2 5BS Tunbridge Wells Kent | British | 11918650001 | ||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Director | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||
| XAVIER, Johann | Director | Charlotte Street W1A 1AQ London 80 United Kingdom | England | Canadian | 115106400004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mms Uk Holdings Limited | 06 abr 2016 | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ALBEMARLE MARKETING RESEARCH LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 15 dic 1997 Entregado el 24 dic 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge | |
Breve descripción By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0