PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00793051 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED?
- Reaseguro de vida (65201) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED?
| Direcci ón de la sede social | C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| VANBRUGH LIFE ASSURANCE LIMITED | 25 feb 1964 | 25 feb 1964 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Bothamley como director el 04 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 10 Fenchurch Avenue London EC3M 5AG a C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX el 17 mar 2023 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 3 Sheldon Square London W2 6PR a 10 Fenchurch Avenue London EC3M 5AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Nombramiento de Ian Bothamley como director el 08 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Anne Owens como director el 30 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 10 Fenchurch Avenue London EC3M 5AG | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2020 au 30 jun 2021 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de M&G Management Services Limited como secretario el 04 oct 2019 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Prudential Group Secretarial Services Limited como secretario el 04 oct 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 20 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 07 ago 2019
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | EC3M 5AG London 10 Fenchurch Avenue |
| 150456660001 | ||||||||||
| FITZGERALD, Sean Andrew | Director | Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham C/O Mazars Llp 1st Floor | Scotland | British | 259031790001 | |||||||||
| RUPAREL, Vanessa Frances | Secretario | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | 66822710002 | ||||||||||
| WALKER, Robert | Secretario | 6 Albion Road RH2 7JY Reigate Surrey | British | 61132230001 | ||||||||||
| WALKER, Robert | Secretario | 6 Albion Road RH2 7JY Reigate Surrey | British | 61132230001 | ||||||||||
| PRUDENTIAL GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Fenchurch Avenue EC3M 5AG London 10 England | 79384540001 | |||||||||||
| ALLEN, Anthony Simon Echalaz | Director | Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London Laurence Pountney Hill England | British | 97055430001 | ||||||||||
| BEDELL PEARCE, Keith Leonard | Director | 4 The Ridge CR8 3PE Purley Surrey | United Kingdom | British | 9522540001 | |||||||||
| BELSHAM, David John | Director | Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London Laurence Pountney Hill England | United Kingdom | British | 51945120001 | |||||||||
| BERKETT, Neil Anthony | Director | KT10 | England | New Zealander | 145735920001 | |||||||||
| BOTHAMLEY, Ian | Director | Fenchurch Avenue EC3M 5AG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 266946140001 | |||||||||
| CASSONI, Maria Luisa | Director | 125 Providence Square Bermondsey Wall West SE1 2ED London | England | British | 74583340001 | |||||||||
| COOK, Alan Ronald | Director | Orchard Grange 28 Church End Road Shenley Brook End MK5 7AB Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | 53705220002 | |||||||||
| DEEKS, Jeremy Spencer | Director | Laurence Pountney Hill London EC4R 0HH | England | British | 158252870001 | |||||||||
| ELBOURNE, John Kenneth | Director | 1 Lissoms Road CR5 3LE Chipstead Surrey | British | 4792320001 | ||||||||||
| EVERETT, Richard Charles | Director | 23 Stanhope Way Riverhead TN13 2DZ Sevenoaks Kent | British | 91615080001 | ||||||||||
| HANBY, Peter Nicholas | Director | 12 Battledown Close GL52 6RD Cheltenham Gloucestershire | British | 1553180001 | ||||||||||
| HARDING, David Charles Ian | Director | 2 Castle Grove CV8 1NF Kenilworth Warwickshire | British | 92569260001 | ||||||||||
| HARRIS, Rosemary | Director | The Mount GU2 4JB Guildford 74 Surrey | England | British | 228468970001 | |||||||||
| HAWES, Michael James Lifford Macnaughtan, Mr. | Director | Laurence Pountney Hill London EC4R 0HH | England | British | 181399720001 | |||||||||
| HURD, Brian Willian | Director | 70 Stamford Road WA14 2JF Bowden Cheshire | England | United Kingdom | 99461690001 | |||||||||
| JACK, James White | Director | Azalea Cottage Alderton Drive HP4 1NA Little Gaddesden Hertfordshire | England | British | 191658610001 | |||||||||
| JACK, James White | Director | Azalea Cottage Alderton Drive HP4 1NA Little Gaddesden Hertfordshire | England | British | 191658610001 | |||||||||
| MITCHELL, James Charles | Director | 4 Strachan Crescent FK14 7HL Dollar Clackmannanshire | British | 26179390001 | ||||||||||
| MOORES, Michael John | Director | 94 The Avenue TW16 5EX Sunbury On Thames Middlesex | United Kingdom | British | 17690270001 | |||||||||
| NICOLSON, Roy Macdonald | Director | 'Ardgarten' 45 Doune Road FK15 9HR Dunblane Perthshire | British | 238750001 | ||||||||||
| NUNN, Kelvin | Director | Pountney Hill EC4R 0HH London Laurence | United Kingdom | British | 109126660001 | |||||||||
| O'DWYER, Finbar Anthony | Director | Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London Laurence Pountney Hill England | Scotland | Irish | 133418790001 | |||||||||
| OWENS, Jennifer Anne | Director | Fenchurch Avenue EC3M 5AG London 10 | England | British | 113688770001 | |||||||||
| PULLEN, Trevor Keith | Director | Loxwood Grassy Lane TN13 1PL Sevenoaks Kent | British | 80114850001 | ||||||||||
| ROBERTSON, Angus John | Director | 48 Kilpatrick Gardens Clarkston G76 7RH Glasgow | British | 64974900001 | ||||||||||
| ROBERTSON, William John | Director | 4 Cavendish Drive Newton Mearns G77 5NY Glasgow | Scotland | British | 145428580001 | |||||||||
| SHAUGHNESSY, Gary Paul John | Director | Wheathold Farm Wolverton RG26 5SA Tadley Hampshire | United Kingdom | British | 153315930001 | |||||||||
| SHEPPARD, Morag Helen | Director | The Station House FK9 3JX Arnprior Stirlingshire | British | 118314860001 | ||||||||||
| STEWART, Gavin Macneill | Director | 17 Baldernock Road Milngavie G62 8DU Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 4844910002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Prudential Assurance Company Limited | 06 abr 2016 | Fenchurch Avenue EC3M 5AG London 10 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creado el 30 jun 2005 Entregado el 21 jul 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of floating charge all the chargor's right to and title and interest in the charged property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene PRUDENTIAL HOLBORN LIFE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0